


Osage County Cousins
Genealogy for Banks - Parson - Kemple - Mantle - Monroe - Redden - Butler Families

Susannah Carter

( = Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
- 1 Susannah Carter [1] b. 1650 d. 14 Dec 1699
Thomas Williamson b. 1656 d. 1744
- 2 Sarah A Williamson [1.1]
b. 1679 d. 1733
John Kirby, Jr b. 18 Apr 1741 d. 11 Mar 1795
- 3 Judith Kirby [1.1.1]
b. 1699 d. 28 Apr 1764
John Puckett b. 1696 d. 28 Apr 1764
- 4 Frances Polly Puckett [1.1.1.1]
b. 1714 d. 1804
- 4 William Puckett [1.1.1.2]
b. 1716 d. 1764
- 4 John Puckett [1.1.1.3]
b. 1716 d. 9 Jul 1765
- 4 Daniel Puckett [1.1.1.4]
b. 1718
- 4 Joel Puckett [1.1.1.5]
b. 11 Nov 1723 d. 1764
- 4 Sheppallin Allen Puckett [1.1.1.6]
b. 8 Nov 1725 d. 29 Mar 1782
- 4 Phebe D Puckett [1.1.1.7]
b. 2 Jan 1728 d. 28 Apr 1764
- 4 Stephen Puckett [1.1.1.8]
b. 17 Oct 1728 d. 27 May 1821
- 4 Drury P Puckett, Sr [1.1.1.9]
b. 25 Jan 1733 d. 26 Jan 1794
Judith Roban b. 1737 d. 26 Jan 1794
- 5 George Washington Puckett, Sr [1.1.1.9.1]
b. 1762 d. 8 Sep 1835
- + Lucy Jane Matthews b. Abt 1775 d. Feb 1850
- + Lucy Jane Matthews b. Abt 1775 d. Feb 1850
- 5 John W Puckett [1.1.1.9.2]
b. 26 Feb 1764 d. 4 Sep 1844
Rhoda Lyda b. 4 Sep 1784 d. 1856
- 6 Mary Polly Puckett [1.1.1.9.2.1]
b. 1811 d. 1880
- 6 Matilda Puckett [1.1.1.9.2.2]
b. 1813 d. 1885
- 6 George W Puckett [1.1.1.9.2.3]
b. 6 Oct 1814 d. 15 Aug 1900
Nancy A Isbell b. 26 Aug 1822 d. 11 Oct 1891
- 7 Caledonia Puckett [1.1.1.9.2.3.1]
b. Jan 1842 d. 1843
- 7 Marion Puckett [1.1.1.9.2.3.2]
b. 1844 d. 1895
- 7 Lavina Puckett [1.1.1.9.2.3.3]
b. 5 Nov 1845 d. Bef 1860
- 7 Sarena J Puckett [1.1.1.9.2.3.4]
b. 5 Nov 1845 d. 12 Dec 1918
- 7 Lafayette Puckett [1.1.1.9.2.3.5]
b. 23 Aug 1846 d. 15 Nov 1934
- 7 George Puckett [1.1.1.9.2.3.6]
b. 1851 d. 30 Sep 1918
- 7 Nancy Puckett [1.1.1.9.2.3.7]
b. 11 Aug 1852 d. 2 Oct 1920
- 7 Lillie Puckett [1.1.1.9.2.3.8]
b. Feb 1855 d. 14 Oct 1915
- 7 Prettyman Puckett [1.1.1.9.2.3.9]
b. 1857 d. 1895
- 7 Martha Puckett [1.1.1.9.2.3.10]
b. 23 Sep 1863 d. 1863
- 7 Napoleon Bonaparte Puckett [1.1.1.9.2.3.11]
b. 23 Sep 1863 d. 20 Nov 1933
- 7 Shelia Puckett [1.1.1.9.2.3.12]
b. Abt 1886
- 7 Dewey A Puckett [1.1.1.9.2.3.13]
b. Abt 1898
- 7 Caledonia Puckett [1.1.1.9.2.3.1]
- 6 Henry Lyda Puckett [1.1.1.9.2.4]
b. 16 Oct 1816 d. 25 Oct 1885
- 6 Nancy Elizabeth Puckett [1.1.1.9.2.5]
b. 18 Mar 1819 d. Jul 1897
- 6 Malinda Pucket [1.1.1.9.2.6]
b. 19 Aug 1820 d. 19 Mar 1884
Elijah Smith b. 6 Oct 1808 d. 9 Nov 1876
- 7 Lucinda Smith [1.1.1.9.2.6.1]
b. 24 Jan 1839 d. 10 Aug 1925
- 7 Russell M Smith [1.1.1.9.2.6.2]
b. 16 Feb 1840 d. 24 Jan 1897
- 7 Madison L Smith [1.1.1.9.2.6.3]
b. 1842
- 7 Pleasant W Smith [1.1.1.9.2.6.4]
b. Abt 1844 d. 1900
- 7 Anna Smith [1.1.1.9.2.6.5]
b. 9 Feb 1844 d. 1 Feb 1933
- 7 George Washington Smith [1.1.1.9.2.6.6]
b. 14 Feb 1845 d. 26 Jun 1924
- 7 Rhoda L Smith [1.1.1.9.2.6.7]
b. 26 Apr 1848 d. 18 Jul 1913
- 7 Mary Jeanette Smith [1.1.1.9.2.6.8]
b. 18 Mar 1849 d. 11 Apr 1931
- 7 Elijah Wiley Smith [1.1.1.9.2.6.9]
b. 1 Oct 1850 d. 4 Dec 1933
- 7 Elizabeth H Smith [1.1.1.9.2.6.10]
b. 1 Oct 1850
- 7 Orpha J Smith [1.1.1.9.2.6.11]
b. Mar 1851 d. Abt 1922
- 7 Nancy Jane Smith [1.1.1.9.2.6.12]
b. Abt 1853
- 7 Henry P Smith [1.1.1.9.2.6.13]
b. 28 Dec 1853 d. 25 Sep 1929
- 7 Andrew Jackson Smith [1.1.1.9.2.6.14]
b. 1856 d. 25 Dec 1922
Mary Jane Cubbins b. 1858 d. Abt 1910
- 8 Claude Smith [1.1.1.9.2.6.14.1]
b. Jun 1880 d. Bef 1909
- 8 Emma Smith [1.1.1.9.2.6.14.2]
b. Jul 1883 d. Bef 1912
- 8 Ella Mae Smith [1.1.1.9.2.6.14.3]
b. 1890 d. 1940
- 8 James B Smith [1.1.1.9.2.6.14.4]
b. 11 Aug 1890 d. 31 Mar 1960
- 8 Eula Lee Smith [1.1.1.9.2.6.14.5]
b. 23 Aug 1894 d. 15 Jun 1974
- 8 William Robert Smith [1.1.1.9.2.6.14.6]
b. 24 Dec 1896 d. 6 Jan 1972
- 8 Charles Vincent Smith [1.1.1.9.2.6.14.7]
b. 23 Sep 1897 d. 9 Apr 1940
- 8 Claude Smith [1.1.1.9.2.6.14.1]
Laura Belle Kilby b. 20 Jan 1889 d. Feb 1984
- 8 Margaret Smith [1.1.1.9.2.6.14.8]
b. 1914
- 8 Virginia Rose Smith [1.1.1.9.2.6.14.9]
b. 1 Apr 1919 d. 10 Feb 1995
- 8 Margaret Smith [1.1.1.9.2.6.14.8]
- 7 Horace Monroe Smith [1.1.1.9.2.6.15]
b. 2 Apr 1858 d. 15 Dec 1935
Mary Della Smith b. 27 Dec 1873 d. 10 Jul 1946
- 8 Millard Holland Smith [1.1.1.9.2.6.15.1]
b. 27 Apr 1892 d. 19 Nov 1968
Augusta Valeska Elizabeth Koeppen b. 17 Aug 1893 d. 1 May 1956
- 9 Louise Marie Smith [1.1.1.9.2.6.15.1.1]
b. 5 Aug 1919 d. 17 Jan 1984
John William Seregow b. 28 Jul 1915 d. 11 May 1996
- 10 J.J. Seregow [1.1.1.9.2.6.15.1.1.1]
- 10 Paul John Seregow [1.1.1.9.2.6.15.1.1.2]
b. 11 Oct 1942 d. 18 Oct 2004
A.R. Trantham
- 11 M. Seregow [1.1.1.9.2.6.15.1.1.2.1]
- 11 D. Seregow [1.1.1.9.2.6.15.1.1.2.2]
- 11 M. Seregow [1.1.1.9.2.6.15.1.1.2.1]
- 10 E.M. Seregow [1.1.1.9.2.6.15.1.1.3]
R.L. Hillegas
- 11 E. Hillegas [1.1.1.9.2.6.15.1.1.3.1]
- 11 G.L. Hillegas [1.1.1.9.2.6.15.1.1.3.2]
- 11 E. Hillegas [1.1.1.9.2.6.15.1.1.3.1]
- 10 J.J. Seregow [1.1.1.9.2.6.15.1.1.1]
- 9 Dorothy Mae Smith [1.1.1.9.2.6.15.1.2]
b. 7 Jun 1924 d. 19 Aug 2019
Marion Joseph Watson b. 21 Feb 1919 d. 19 Aug 2006
- 10 K.D. Watson [1.1.1.9.2.6.15.1.2.1]
- + T. _____
- + T. _____
- 10 M.M. Watson [1.1.1.9.2.6.15.1.2.2]
- + J. ____
- + J. ____
- 10 B.A. Watson [1.1.1.9.2.6.15.1.2.3]
- + D. _____
- + D. _____
- 10 K.D. Watson [1.1.1.9.2.6.15.1.2.1]
- 9 Louise Marie Smith [1.1.1.9.2.6.15.1.1]
- 8 Astor Waldo Smith [1.1.1.9.2.6.15.2]
b. 21 Feb 1895 d. 31 Dec 1967
- 8 William Thurlow Smith [1.1.1.9.2.6.15.3]
b. 13 Jan 1898 d. 2 Jan 1912
- 8 Horace Monroe Smith, Jr [1.1.1.9.2.6.15.4]
b. 12 Apr 1901 d. 19 Sep 1912
- 8 Letha Melvina Smith [1.1.1.9.2.6.15.5]
b. 21 Jul 1904 d. 13 Jul 1905
- 8 Ivan Leo Smith [1.1.1.9.2.6.15.6]
b. 23 Sep 1905 d. 15 Apr 1989
- 8 Oral Kingsberry Smith [1.1.1.9.2.6.15.7]
b. 23 Jul 1910 d. 29 Oct 1998
- 8 Levi Lawrence Smith [1.1.1.9.2.6.15.8]
b. 23 Sep 1914 d. 12 Dec 1970
- 8 Millard Holland Smith [1.1.1.9.2.6.15.1]
- 7 Andrew Johnson Smith [1.1.1.9.2.6.16]
b. 9 Mar 1859 d. 25 Dec 1922
- 7 Amon D Smith [1.1.1.9.2.6.17]
b. Dec 1859
- 7 Nicy Belle Smith [1.1.1.9.2.6.18]
b. 1862 d. 27 Apr 1904
- 7 Lucinda Smith [1.1.1.9.2.6.1]
- 6 Marinda Puckett [1.1.1.9.2.7]
b. 15 Oct 1822 d. 18 Mar 1884
- 6 James S Puckett [1.1.1.9.2.8]
b. Jun 1823 d. 14 Nov 1913
- 6 Purtanam (Prettyman) Puckett [1.1.1.9.2.9]
b. 1824 d. 1875
- 6 John Puckett [1.1.1.9.2.10]
b. Abt 1828 d. Abt 1900
- 6 E W D Puckett [1.1.1.9.2.11]
b. Abt 1832 d. 1901
- 6 Daniel L Puckett [1.1.1.9.2.12]
b. 5 Dec 1832 d. 23 Feb 1887
Lecia C Wilkerson b. 2 Jun 1844 d. 18 Jul 1877
- 7 Alvin Josephus Puckett [1.1.1.9.2.12.1]
b. Jul 1860 d. 9 May 1926
- 7 Martha Ann Puckett [1.1.1.9.2.12.2]
b. 1863 d. 12 Aug 1936
- 7 Amanda H Puckett [1.1.1.9.2.12.3]
b. 6 Aug 1865 d. 8 Jul 1950
John Milton Street b. 17 Dec 1864 d. 1942
- 8 J.M. Street, III [1.1.1.9.2.12.3.1]
- 8 Elmer Oddey Street [1.1.1.9.2.12.3.2]
b. 16 Jun 1890 d. 17 Jan 1981
- 8 J.M. Street, III [1.1.1.9.2.12.3.1]
- 7 Marinda E Puckett [1.1.1.9.2.12.4]
b. 18 Nov 1867 d. 8 Jul 1950
- 7 Laura Elizabeth Puckett [1.1.1.9.2.12.5]
b. 3 Mar 1870 d. 8 May 1909
- 7 George Washington Puckett [1.1.1.9.2.12.6]
b. 8 Oct 1873 d. 25 May 1965
- + Florence A Puckett b. Abt 1873
- + Florence A Puckett b. Abt 1873
- 7 Daniel Webster Puckett [1.1.1.9.2.12.7]
b. 15 Apr 1874 d. 25 May 1965
Susan Agnes Davis b. 7 Feb 1882 d. 15 Aug 1967
- 8 Clyde Puckett [1.1.1.9.2.12.7.1]
b. 14 Nov 1906 d. 28 Jan 2001
Gladys Johnson b. 3 Oct 1906 d. 7 Jan 1990
- 9 Norma Ruth Puckett, meyers [1.1.1.9.2.12.7.1.1]
b. 3 Jul 1931 d. 10 Oct 2021
- 9 E.S. Puckett [1.1.1.9.2.12.7.1.2]
- 9 Norma Ruth Puckett, meyers [1.1.1.9.2.12.7.1.1]
- 8 Vern L Puckett [1.1.1.9.2.12.7.2]
b. 27 Oct 1908 d. 11 Jan 1987
Zela V Arnold b. 5 May 1909 d. 10 Dec 2001
- 9 Max Arnold Puckett [1.1.1.9.2.12.7.2.1]
b. 14 Jul 1932 d. 1 Apr 1992
- 9 Lou Alice Puckett [1.1.1.9.2.12.7.2.2]
b. 5 Dec 1937 d. 16 Sep 2012
- 9 Max Arnold Puckett [1.1.1.9.2.12.7.2.1]
- 8 Bern Puckett [1.1.1.9.2.12.7.3]
b. 1909
Zela V Puckett b. Abt 1909 d. 12 Dec 2001
- 9 M.A. Puckett [1.1.1.9.2.12.7.3.1]
- 9 L.A. Puckett [1.1.1.9.2.12.7.3.2]
- 9 M.A. Puckett [1.1.1.9.2.12.7.3.1]
- 8 Olen Clifton Puckett [1.1.1.9.2.12.7.4]
b. 5 Aug 1910 d. 29 Dec 1984
Marie F Bonham b. 27 Jan 1912 d. 18 Mar 1995
- 9 Jo Angelyn Puckett [1.1.1.9.2.12.7.4.1]
b. 28 Mar 1940 d. 15 Sep 1994
- 9 Jo Angelyn Puckett [1.1.1.9.2.12.7.4.1]
- 8 Ruth Lanell Puckett [1.1.1.9.2.12.7.5]
b. 9 Jun 1912 d. 10 Dec 2002
Frank Andrews b. Abt 1912 d. 30 Sep 1986
- 9 John F Andrews [1.1.1.9.2.12.7.5.1]
b. 10 Jul 1930 d. 10 Apr 2011
- 9 Charles Andrews [1.1.1.9.2.12.7.5.2]
b. Abt 1934 d. 27 Aug 1985
- 9 John F Andrews [1.1.1.9.2.12.7.5.1]
- 8 Edwin Deal Puckett [1.1.1.9.2.12.7.6]
b. 23 Jun 1914 d. 22 Dec 2005
Lanell Price b. 4 Jan 1917 d. 26 Jul 2005
- 9 Joann Puckett [1.1.1.9.2.12.7.6.1]
- 9 Carolyn Sue Puckett [1.1.1.9.2.12.7.6.2]
b. 27 Mar 1938 d. 8 Jun 1987
- 9 Joann Puckett [1.1.1.9.2.12.7.6.1]
- 8 Daniel Wayne Puckett [1.1.1.9.2.12.7.7]
b. 19 Mar 1917 d. 3 Dec 2006
Irene Frances Harral b. 25 Feb 1920 d. 3 Sep 2007
- 8 George Washinton Puckett, Jr [1.1.1.9.2.12.7.8]
b. 16 Jun 1922 d. 3 Jul 2006
Novela Catherine Wilkins b. 13 Jan 1925 d. 20 Dec 2016
- 9 J.G. Puckett [1.1.1.9.2.12.7.8.1]
- 9 J.G. Puckett [1.1.1.9.2.12.7.8.1]
- 8 Clyde Puckett [1.1.1.9.2.12.7.1]
- 7 Alvin Josephus Puckett [1.1.1.9.2.12.1]
Nancy Adeline Andrews b. 3 Oct 1845 d. 10 Feb 1888
- 7 Ester Puckett [1.1.1.9.2.12.8]
b. Oct 1881
- 7 Mary Adeline Puckett [1.1.1.9.2.12.9]
b. 14 Oct 1884 d. 15 Apr 1957
William Spenser Sullivan, Jr b. 27 Mar 1879 d. 3 Jul 1930
- 8 Roy Tillman Sullivan [1.1.1.9.2.12.9.1]
b. 15 Jun 1901 d. 25 May 1977
- 8 William Earnest Sullivan [1.1.1.9.2.12.9.2]
b. 23 Dec 1902 d. 1997
Johnnie Faye Harrod b. 16 Aug 1913 d. 17 Feb 1986
- 9 Mary Jeanette Sullivan [1.1.1.9.2.12.9.2.1]
b. 22 Jun 1939 d. 5 Feb 2008
- 9 W.E. Sullivan [1.1.1.9.2.12.9.2.2]
- 9 Mary Jeanette Sullivan [1.1.1.9.2.12.9.2.1]
- 8 Lois Sullivan [1.1.1.9.2.12.9.3]
b. 1904 d. 1906
- 8 Michael Nathaniel Sullivan [1.1.1.9.2.12.9.4]
b. 6 Feb 1907 d. 7 Mar 1986
- 8 Patrick Henry Sullivan [1.1.1.9.2.12.9.5]
b. 27 Mar 1909 d. 23 Oct 1996
- 8 Otto Warren Sullivan [1.1.1.9.2.12.9.6]
b. 4 Aug 1911 d. 3 Nov 1933
- 8 Robert Haskell Sullivan [1.1.1.9.2.12.9.7]
b. 26 Jul 1913 d. 26 May 1993
- 8 Robert H Sullivan [1.1.1.9.2.12.9.8]
b. Abt 1915 d. 1916
- 8 Charles Sullivan [1.1.1.9.2.12.9.9]
b. 25 Sep 1915 d. 8 Feb 2010
Frances Emily Sanders b. 29 Feb 1916 d. 10 Jul 1973
- 9 Charles Frank Sullivan [1.1.1.9.2.12.9.9.1]
b. 5 Apr 1938 d. 15 Sep 1983
- 9 C. Sullivan [1.1.1.9.2.12.9.9.2]
- 9 C. Sullivan [1.1.1.9.2.12.9.9.3]
- 9 Randall Lee (Winkers) Sullivan [1.1.1.9.2.12.9.9.4]
b. 20 Oct 1954 d. 13 Sep 2013
- 9 Charles Frank Sullivan [1.1.1.9.2.12.9.9.1]
- 8 Sarah Sullivan [1.1.1.9.2.12.9.10]
b. 1918
- 8 Pearl Lee Sullivan [1.1.1.9.2.12.9.11]
b. 2 Sep 1918 d. 17 May 2000
- 8 Pearl L Sullivan [1.1.1.9.2.12.9.12]
b. Abt 1919
Adrial Harrod b. Abt 1910
- 9 B.J. Harrod [1.1.1.9.2.12.9.12.1]
- 9 J.S. Harrod [1.1.1.9.2.12.9.12.2]
- 9 J.W. Harrod [1.1.1.9.2.12.9.12.3]
- 9 A.W. Harrod, Jr [1.1.1.9.2.12.9.12.4]
- 9 D.H. Harrod [1.1.1.9.2.12.9.12.5]
- 9 B.J. Harrod [1.1.1.9.2.12.9.12.1]
- 8 Gladys May Sullivan [1.1.1.9.2.12.9.13]
b. Feb 1920 d. Apr 1920
- 8 Mildred Marie Sullivan [1.1.1.9.2.12.9.14]
b. 22 Oct 1922 d. 30 Jan 1999
Robert Wayne Mosley b. 1 Dec 1919 d. 23 May 2007
- 9 James W Mosley [1.1.1.9.2.12.9.14.1]
b. Abt 1872
- 9 P.A. Mosley [1.1.1.9.2.12.9.14.2]
- 9 D.L. Mosley [1.1.1.9.2.12.9.14.3]
- 9 Robert Edward Mosley [1.1.1.9.2.12.9.14.4]
b. 11 Nov 1950 d. 16 May 2021
- 9 Robin Kay Chambers [1.1.1.9.2.12.9.14.5]
b. 1 Mar 1959 d. 1 Jul 2007
- 9 Bonnie Belle Mosley [1.1.1.9.2.12.9.14.6]
b. 25 Mar 1962 d. 25 Mar 1962
- 9 James W Mosley [1.1.1.9.2.12.9.14.1]
- 8 Winifred Sullivan [1.1.1.9.2.12.9.15]
b. 12 Jan 1925 d. 13 Dec 1999
Arthur William Giggleman, Jr b. 11 Sep 1923 d. 5 Mar 2006
- 9 Arthur Paul Giggleman [1.1.1.9.2.12.9.15.1]
b. 4 Jan 1945 d. 25 Nov 1960
- 9 C. Giggleman [1.1.1.9.2.12.9.15.2]
- 9 Arthur Paul Giggleman [1.1.1.9.2.12.9.15.1]
- 8 Mary Willenne Sullivan [1.1.1.9.2.12.9.16]
b. 1926 d. 4 Dec 1970
Frank M Rose b. 30 Nov 1923 d. Aug 1988
- 9 F.W. Rose [1.1.1.9.2.12.9.16.1]
- 9 F.W. Rose [1.1.1.9.2.12.9.16.1]
- 8 Roy Tillman Sullivan [1.1.1.9.2.12.9.1]
- 7 Matilda Adeline Puckett [1.1.1.9.2.12.10]
b. 21 Sep 1886 d. 3 Nov 1976
- + John Andrew Tompkins b. Abt 1877 d. 7 May 1938
- + John Andrew Tompkins b. Abt 1877 d. 7 May 1938
- 7 Ester Puckett [1.1.1.9.2.12.8]
- 6 Mary Polly Puckett [1.1.1.9.2.1]
- 5 Rosannah Jannie Puckett [1.1.1.9.3]
b. 14 Dec 1766 d. 1845
Robert S Monroe, Sr b. 1763 d. 6 May 1836
- 6 George William Monroe [1.1.1.9.3.1]
b. 14 Apr 1782 d. 14 Oct 1869
Margaret Elizabeth Peters b. 1 Jan 1786 d. 14 Sep 1873
- 7 Robert Monroe [1.1.1.9.3.1.1]
b. 1811 d. Aft 1880
Mary Polly Fields b. 1812 d. 8 Mar 1852
- 8 James William Monroe [1.1.1.9.3.1.1.1]
b. Apr 1829 d. 17 Apr 1900
- 8 Mary (Polly) Monroe [1.1.1.9.3.1.1.2]
b. 1830 d. 1831
- 8 Elizabeth Monroe [1.1.1.9.3.1.1.3]
b. 30 Oct 1831 d. 19 Jan 1911
- 8 Louisa Bell Monroe [1.1.1.9.3.1.1.4]
b. 1835 d. 1884
- 8 Elisha Monroe [1.1.1.9.3.1.1.5]
b. 1837 d. 1838
- 8 Mahala Ann Monroe [1.1.1.9.3.1.1.6]
b. 1839 d. 1874
- 8 Elijah Monroe [1.1.1.9.3.1.1.7]
b. 1842 d. 1843
- 8 Sanders Alexander Monroe [1.1.1.9.3.1.1.8]
b. 5 Apr 1843 d. 9 Aug 1887
- 8 William Monroe [1.1.1.9.3.1.1.9]
b. 1846 d. 1847
- 8 Calvin Monroe [1.1.1.9.3.1.1.10]
b. 1848 d. 1849
- 8 Jesse Monroe [1.1.1.9.3.1.1.11]
b. 16 Sep 1850 d. 1851
- 8 George W Monroe [1.1.1.9.3.1.1.12]
b. 1852
- 8 James William Monroe [1.1.1.9.3.1.1.1]
Elizabeth Prudence Mathena b. Apr 1825
- 8 Tobe Alvin Monroe [1.1.1.9.3.1.1.13]
b. 29 Dec 1862 d. 29 Apr 1922
- 8 Tobe Alvin Monroe [1.1.1.9.3.1.1.13]
- 7 Margaret Monroe [1.1.1.9.3.1.2]
b. 1812 d. 24 Dec 1904
Morris R Hardin b. 1814 d. 1841
- 8 S. Hardin [1.1.1.9.3.1.2.1]
- 8 Sarah Elizabeth Hardin [1.1.1.9.3.1.2.2]
b. 31 Jul 1837 d. 6 Feb 1911
- 8 John B Hardin [1.1.1.9.3.1.2.3]
b. 1840
- 8 George W Hardin [1.1.1.9.3.1.2.4]
b. 1841 d. 26 Mar 1863
- 8 S. Hardin [1.1.1.9.3.1.2.1]
- 7 George William Monroe, Jr [1.1.1.9.3.1.3]
b. 1815 d. Bef 1865
Elizabeth Pearson b. 1815 d. 1853
- 8 Jesse Lafayette Monroe [1.1.1.9.3.1.3.1]
b. 7 Feb 1841 d. 22 Feb 1916
- 8 Sherwood M Monroe [1.1.1.9.3.1.3.2]
b. 1842 d. 1875
Ruth Matilda McKeehan b. Feb 1848 d. Abt 1925
- 9 George Washington Monroe [1.1.1.9.3.1.3.2.1]
b. 23 Jun 1864 d. 5 Nov 1946
- 9 Martha Paralee Monroe [1.1.1.9.3.1.3.2.2]
b. 14 Feb 1871 d. 12 Oct 1943
- 9 Samuel Thomas Monroe [1.1.1.9.3.1.3.2.3]
b. 7 Feb 1872 d. 29 Sep 1933
- 9 Elizabeth Belle Monroe [1.1.1.9.3.1.3.2.4]
b. 13 Oct 1873 d. 7 Nov 1960
- 9 George Washington Monroe [1.1.1.9.3.1.3.2.1]
- 8 Samantha J Monroe [1.1.1.9.3.1.3.3]
b. 19 Oct 1845 d. 9 Jul 1908
- 8 Elizabeth Belle Monroe [1.1.1.9.3.1.3.4]
b. 30 Nov 1847 d. 9 Jan 1900
James L McKeehan b. Abt 1847 d. 3 Jul 1917
- 9 Altie Belle McKeehan [1.1.1.9.3.1.3.4.1]
b. 25 Sep 1899 d. 26 Oct 1985
- + Wesley F Gregory b. Abt 1892
- + Wesley F Gregory b. Abt 1892
- 9 Altie Belle McKeehan [1.1.1.9.3.1.3.4.1]
- 8 Horace Monroe [1.1.1.9.3.1.3.5]
b. 1849 d. 1860
- 8 Millard F Monroe [1.1.1.9.3.1.3.6]
b. 10 Sep 1852 d. 17 May 1883
- 8 Jesse Lafayette Monroe [1.1.1.9.3.1.3.1]
- + Margaret Simpson b. 21 Jan 1822 d. 26 Mar 1915
- 7 Catherine Monroe [1.1.1.9.3.1.4]
b. 1817 d. Apr 1874
Lide Wiles Dobbs b. 14 Feb 1820 d. 18 May 1862
- 8 Sarah J Dobbs [1.1.1.9.3.1.4.1]
b. 1848
- 8 George Wiles Dobbs [1.1.1.9.3.1.4.2]
b. 1850
- 8 Margaret E Dobbs [1.1.1.9.3.1.4.3]
b. 16 Aug 1850 d. 9 Apr 1925
- 8 George Washington Dobbs [1.1.1.9.3.1.4.4]
b. 16 Sep 1854 d. 29 Feb 1920
- 8 Mary E Dobbs [1.1.1.9.3.1.4.5]
b. 1858
- 8 Sarah J Dobbs [1.1.1.9.3.1.4.1]
- 7 Joseph Marion Monroe [1.1.1.9.3.1.5]
b. 1818 d. 20 Feb 1865
Harriet Newell Davis b. 2 Oct 1829 d. 20 Jul 1898
- 8 Mary E Jane Monroe [1.1.1.9.3.1.5.1]
b. 23 Sep 1848 d. 18 Dec 1885
- 8 William M Monroe [1.1.1.9.3.1.5.2]
b. 4 Feb 1850 d. 25 Dec 1934
- 8 Margaret Elizabeth Monroe [1.1.1.9.3.1.5.3]
b. 4 Feb 1850 d. 30 Sep 1907
- 8 Horace Lee Monroe [1.1.1.9.3.1.5.4]
b. 2 Jun 1856 d. 23 Mar 1934
- 8 Charles B Monroe [1.1.1.9.3.1.5.5]
b. 1857 d. 9 Nov 1914
- 8 Joseph Marion Monroe, Jr [1.1.1.9.3.1.5.6]
b. 1 Dec 1859 d. 14 Jul 1926
- 8 Sarah A Monroe [1.1.1.9.3.1.5.7]
b. 10 Jun 1861 d. 17 Apr 1899
- + W. Lyles
- + W. Lyles
- 8 Elizabeth P ( Betty) Monroe [1.1.1.9.3.1.5.8]
b. 24 Apr 1864 d. 13 Jul 1899
- 8 George W Monroe [1.1.1.9.3.1.5.9]
b. 24 Apr 1864 d. 5 Jan 1936
- 8 Mary E Jane Monroe [1.1.1.9.3.1.5.1]
- 7 Robert Monroe [1.1.1.9.3.1.1]
- 6 Mary (Polly) Monroe [1.1.1.9.3.2]
b. 1785 d. 17 Dec 1819
- + Richard Atkins b. 1788 d. 1836
- + Richard Atkins b. 1788 d. 1836
- 6 Elizabeth Monroe [1.1.1.9.3.3]
b. 5 Dec 1785 d. 7 Dec 1865
Lewis M Atkins b. 5 May 1785 d. 14 Jan 1865
- 7 Margaret Atkins [1.1.1.9.3.3.1]
b. 20 Mar 1805 d. Aft 1850
- + Presley Burnett b. Abt 1802
- + Presley Burnett b. Abt 1802
- 7 Nancy Atkins [1.1.1.9.3.3.2]
b. 4 Nov 1808 d. 1 Jun 1890
Archibald Mullens b. 24 Jan 1805 d. 19 Apr 1890
- 8 E. Mullens [1.1.1.9.3.3.2.1]
- 8 Alvis Mullens [1.1.1.9.3.3.2.2]
b. 5 Jun 1829 d. 15 Sep 1829
- 8 Anna Emeline Mullens [1.1.1.9.3.3.2.3]
b. 1 Jul 1830 d. 24 Feb 1898
W. Marks
- 9 William Henry Marks, Sr [1.1.1.9.3.3.2.3.1]
b. 8 Nov 1865 d. 15 Dec 1933
Elizabeth M Franklin b. 9 Mar 1874 d. 25 Apr 1956
- 10 Lottie Marks [1.1.1.9.3.3.2.3.1.1]
b. 1891 d. 1980
- 10 Howard Marks [1.1.1.9.3.3.2.3.1.2]
b. 27 Jul 1893 d. 17 Oct 1918
- 10 William Henry Marks, Sr [1.1.1.9.3.3.2.3.1.3]
b. 19 Dec 1894 d. 15 Apr 1972
- 10 Richard Marks [1.1.1.9.3.3.2.3.1.4]
b. 22 Nov 1897 d. 23 Mar 1932
- + Frances Marks b. Abt 1906
- + Lucille Marks b. 29 Apr 1896 d. 8 Jul 1978
- + Frances Marks b. Abt 1906
- 10 Lucy Eva Marks [1.1.1.9.3.3.2.3.1.5]
b. 29 Jul 1899 d. 17 Nov 1963
John R Seng b. Abt 1892
- 10 Martha Marks [1.1.1.9.3.3.2.3.1.6]
b. 11 Oct 1903 d. 8 Apr 1974
- 10 Joseph Franklion Marks [1.1.1.9.3.3.2.3.1.7]
b. 24 Oct 1908 d. 26 Nov 1987
Erma Marie Himes b. 20 Sep 1912 d. 26 Aug 1996
- 11 Kathleen Alma Marks [1.1.1.9.3.3.2.3.1.7.1]
b. 27 Nov 1939 d. 28 Apr 2012
- 11 Charles Edward Marks [1.1.1.9.3.3.2.3.1.7.2]
b. 27 Nov 1939 d. 27 Nov 1939
- 11 Kathleen Alma Marks [1.1.1.9.3.3.2.3.1.7.1]
- 10 Lottie Marks [1.1.1.9.3.3.2.3.1.1]
- 9 William Henry Marks, Sr [1.1.1.9.3.3.2.3.1]
- 8 Elijah Mullens [1.1.1.9.3.3.2.4]
b. 23 Jan 1832 d. 16 Jan 1926
- 8 Sarah Mullens [1.1.1.9.3.3.2.5]
b. 11 Aug 1834 d. 13 Aug 1907
Joel Coffey b. 4 Dec 1826 d. 18 May 1896
- 9 Mary J Coffey [1.1.1.9.3.3.2.5.1]
b. 7 May 1860 d. 24 Aug 1866
- 9 Alta B Coffey [1.1.1.9.3.3.2.5.2]
b. 21 Jul 1871 d. 11 Jul 1880
- 9 Mary J Coffey [1.1.1.9.3.3.2.5.1]
- 8 Elizabeth Mullens [1.1.1.9.3.3.2.6]
b. 7 Oct 1835
- 8 John Mullens, I [1.1.1.9.3.3.2.7]
b. 3 Feb 1838 d. 24 Feb 1928
- 8 Robert Mullens [1.1.1.9.3.3.2.8]
b. 19 Nov 1841 d. 11 Apr 1920
- 8 Julia Louisa Mullens [1.1.1.9.3.3.2.9]
b. 11 Jul 1844 d. Sep 1908
John Henry W McCullin b. 29 Dec 1839 d. 18 Jul 1897
- 9 John Lewis McCullin [1.1.1.9.3.3.2.9.1]
b. 11 Jul 1862 d. 15 Jul 1947
- 9 Emma McCullin [1.1.1.9.3.3.2.9.2]
b. 1864
- 9 Henry Ratliff McCullin [1.1.1.9.3.3.2.9.3]
b. 17 Feb 1864 d. 14 Nov 1938
- 9 William Murray McCullin [1.1.1.9.3.3.2.9.4]
b. 18 Sep 1866 d. 19 Sep 1931
- 9 Willis Murrell McCullin [1.1.1.9.3.3.2.9.5]
b. Abt 1867 d. 14 Nov 1938
- 9 John Lewis McCullin [1.1.1.9.3.3.2.9.1]
- 8 Martha Mullens [1.1.1.9.3.3.2.10]
b. 11 Jun 1847 d. 4 Jun 1909
- 8 Emily Mullens [1.1.1.9.3.3.2.11]
b. 1 Jul 1852 d. 4 Jan 1936
- + Calvin Frost b. 22 Mar 1841 d. 28 Nov 1927
- + Calvin Frost b. 22 Mar 1841 d. 28 Nov 1927
- 8 E. Mullens [1.1.1.9.3.3.2.1]
- 7 Moses Morris Atkins [1.1.1.9.3.3.3]
b. 4 Nov 1808 d. 23 Mar 1859
Mary (Polly) Phipps b. Abt 1806 d. Aft 1850
- 8 Izola Adkins [1.1.1.9.3.3.3.1]
b. Abt 1830 d. Aft 1850
- 8 Elizabeth Atkins [1.1.1.9.3.3.3.2]
b. 1831 d. Aft 1850
- 8 Dellila Atkins [1.1.1.9.3.3.3.3]
b. 1831 d. Abt 1890
- 8 Louisa Adkins [1.1.1.9.3.3.3.4]
b. 19 Mar 1834 d. 25 Apr 1916
- 8 Amanda Adkins [1.1.1.9.3.3.3.5]
b. Abt 1837 d. Aft 1880
- 8 Louis Atkins [1.1.1.9.3.3.3.6]
b. 1849
- 8 Izola Adkins [1.1.1.9.3.3.3.1]
- 7 Nathan Atkins [1.1.1.9.3.3.4]
b. 9 Sep 1811 d. Bef 1850
Anna Needham b. Abt 1811 d. Bef 1850
- 8 Lewis Atkins, Jr [1.1.1.9.3.3.4.1]
b. 26 Sep 1828 d. 10 Mar 1904
- + Elizabeth Jane Atkins b. 26 Jul 1832 d. 8 Mar 1922
- + Elizabeth Jane Atkins b. 26 Jul 1832 d. 8 Mar 1922
- 8 Lurette Adkins [1.1.1.9.3.3.4.2]
b. Abt 1835 d. Bef 1910
Mark M Monroe b. 28 May 1835 d. 19 Jan 1918
- 9 Anna Cordia Monroe [1.1.1.9.3.3.4.2.1]
b. 2 Dec 1854 d. 9 Jan 1932
- 9 Eldridge Monroe [1.1.1.9.3.3.4.2.2]
b. Abt 1857 d. 14 Apr 1950
Amelia Rucker b. 24 May 1857 d. 20 Jun 1936
- 10 Tolbert Prailo Monroe [1.1.1.9.3.3.4.2.2.1]
b. 11 Mar 1885 d. 9 May 1951
Lyda Grace Needham b. 18 May 1885 d. 26 Sep 1970
- 11 Weir Lee Monroe, Sr [1.1.1.9.3.3.4.2.2.1.1]
b. 28 Dec 1904 d. 4 Apr 1997
Estella Corrina Booker b. 20 Jun 1896 d. 31 Aug 1973
- 12 Frances V Monroe [1.1.1.9.3.3.4.2.2.1.1.1]
b. 31 Mar 1925 d. 8 Oct 1990
- 12 Weir Lee Monroe, Jr [1.1.1.9.3.3.4.2.2.1.1.2]
b. 15 Feb 1929 d. 22 Apr 1996 [ =>]
- 12 Morris Hall Monroe, Sr [1.1.1.9.3.3.4.2.2.1.1.3]
b. 7 May 1930 d. 13 Feb 1985
- 12 Frances V Monroe [1.1.1.9.3.3.4.2.2.1.1.1]
- 11 Calma Vaughn Monroe [1.1.1.9.3.3.4.2.2.1.2]
b. 2 May 1916 d. 19 Aug 1999
Hazel C Vandergriff b. 11 Jun 1917 d. 21 Jul 1963
- 12 Harl Lee Monroe [1.1.1.9.3.3.4.2.2.1.2.1]
b. 6 Jun 1939 d. 5 Mar 2015
- 12 L. Monroe [1.1.1.9.3.3.4.2.2.1.2.2]
- 12 Brenda Faye Monroe [1.1.1.9.3.3.4.2.2.1.2.3]
b. 7 Feb 1950 d. 3 Jun 2014
- 12 Harl Lee Monroe [1.1.1.9.3.3.4.2.2.1.2.1]
- + Sara Elizabeth Clement b. 1 Nov 1918 d. 20 Sep 1998
- 11 Frances Maud Monroe [1.1.1.9.3.3.4.2.2.1.3]
b. 25 Nov 1918 d. 10 Sep 1922
- 11 Edna Lucile Monroe [1.1.1.9.3.3.4.2.2.1.4]
b. 4 May 1921 d. 2 Feb 2015
- + Pryor Lee Acuff b. 5 Mar 1908 d. 19 Jan 1998
- + Pryor Lee Acuff b. 5 Mar 1908 d. 19 Jan 1998
- 11 Weir Lee Monroe, Sr [1.1.1.9.3.3.4.2.2.1.1]
- 10 Tolbert Prailo Monroe [1.1.1.9.3.3.4.2.2.1]
- 9 Anna Cordia Monroe [1.1.1.9.3.3.4.2.1]
- 8 Ira Atkins [1.1.1.9.3.3.4.3]
b. 24 Jan 1836 d. 4 Mar 1920
- 8 Tolbert Atkins [1.1.1.9.3.3.4.4]
b. Abt 1839
- 8 Lewis Atkins, Jr [1.1.1.9.3.3.4.1]
- 7 Elijah Atkins [1.1.1.9.3.3.5]
b. 4 May 1814 d. 1895
Elizabeth (Betsey) Mullens b. 18 Mar 1813 d. 1866
- 8 Wesley Sylvestor Atkins [1.1.1.9.3.3.5.1]
b. 20 Oct 1836 d. 30 Nov 1916
Emily Catherine Comer b. 27 Aug 1840 d. 1875
- 9 Martha Jane Atkins [1.1.1.9.3.3.5.1.1]
b. 16 Jun 1860 d. 1876
- 9 John Linville Atkins [1.1.1.9.3.3.5.1.2]
b. 8 May 1862 d. 20 Sep 1884
- 9 Rachel Emily Atkins [1.1.1.9.3.3.5.1.3]
b. 7 Feb 1865 d. 1901
- 9 William Wesley Atkins [1.1.1.9.3.3.5.1.4]
b. 5 Nov 1866 d. 9 May 1929
- 9 Elijah L Atkins [1.1.1.9.3.3.5.1.5]
b. 26 Oct 1869 d. 14 Jun 1956
- + Nola Ann Coram b. Abt 1881
- + Nola Ann Coram b. Abt 1881
- 9 Col Alonzo 'Lonzo' Atkins [1.1.1.9.3.3.5.1.6]
b. 3 Aug 1873 d. 26 Feb 1928
- 9 Martha Jane Atkins [1.1.1.9.3.3.5.1.1]
Nancy Jane Zachary b. 1 Jan 1847 d. 3 May 1917
- 9 Tilman Cornelius (Tim) Atkins [1.1.1.9.3.3.5.1.7]
b. 31 Jul 1878 d. 24 Aug 1956
- 9 Robert Condee 'Carl' Atkins [1.1.1.9.3.3.5.1.8]
b. 26 Sep 1880 d. 15 Oct 1966
- 9 Minnie M Atkins [1.1.1.9.3.3.5.1.9]
b. 14 Feb 1882 d. Sep 1948
- 9 Joseph Garfield Atkins [1.1.1.9.3.3.5.1.10]
b. 4 Jan 1884 d. 16 Nov 1972
Mary E Atkins b. 31 Oct 1910 d. 17 Sep 2004
- 10 D.G. Atkins [1.1.1.9.3.3.5.1.10.1]
- 10 E.A. Atkins [1.1.1.9.3.3.5.1.10.2]
- 10 D.G. Atkins [1.1.1.9.3.3.5.1.10.1]
Mamie Maude Booker b. 22 Jun 1888 d. 17 Dec 1964
- 10 Louis A Atkins [1.1.1.9.3.3.5.1.10.3]
b. Abt 1906 d. 29 Jul 1988
- 10 Andy F Atkins [1.1.1.9.3.3.5.1.10.4]
b. Abt 1909 d. 8 Jul 1994
- 10 Mabel L Atkins [1.1.1.9.3.3.5.1.10.5]
b. Abt 1911 d. 28 Nov 2000
- 10 Hazel Ruth Atkins [1.1.1.9.3.3.5.1.10.6]
b. 31 May 1913 d. 14 Oct 2002
- 10 Roy S Atkins [1.1.1.9.3.3.5.1.10.7]
b. Abt 1916 d. 10 Nov 2005
- 10 Ray Atkin [1.1.1.9.3.3.5.1.10.8]
b. Abt 1916
- 10 Marie M Atkins [1.1.1.9.3.3.5.1.10.9]
b. 3 Apr 1918 d. 19 Jul 2008
- + C Felix Deterding b. 21 May 1914 d. 9 Jun 1988
- + C Felix Deterding b. 21 May 1914 d. 9 Jun 1988
- 10 Lester Clarence Atkins [1.1.1.9.3.3.5.1.10.10]
b. 26 Nov 1920 d. 29 Aug 1991
Mary Lou Mosley b. 11 Dec 1926 d. 1 Feb 2010
- 11 Kathryn Ann Atkins [1.1.1.9.3.3.5.1.10.10.1]
b. 2 Jun 1951 d. 20 Aug 2008
- 11 Kathryn Ann Atkins [1.1.1.9.3.3.5.1.10.10.1]
- 10 Joseph Homer (Jay) Atkins [1.1.1.9.3.3.5.1.10.11]
b. 29 Apr 1943 d. 12 Sep 2021
- 10 Louis A Atkins [1.1.1.9.3.3.5.1.10.3]
- 9 Charles Thornberg Atkins [1.1.1.9.3.3.5.1.11]
b. 28 Oct 1886 d. 24 Nov 1970
C Ethlel Atkins b. Abt 1907
- 10 D.M. Atkins [1.1.1.9.3.3.5.1.11.1]
- 10 O.J. Atkins [1.1.1.9.3.3.5.1.11.2]
- 10 M.A. Atkins [1.1.1.9.3.3.5.1.11.3]
- 10 C.T. Atkins, Jr [1.1.1.9.3.3.5.1.11.4]
- 10 D.M. Atkins [1.1.1.9.3.3.5.1.11.1]
- 9 James Arlie Atkins [1.1.1.9.3.3.5.1.12]
b. 22 Oct 1888 d. 11 Mar 1968
- + Ella May Archer b. 22 Apr 1894 d. 8 Aug 1915
Ida Ella Sharp b. 2 Feb 1897 d. 15 Dec 1989
- 10 Nancy Niona Jane Atkins [1.1.1.9.3.3.5.1.12.1]
b. 16 Mar 1918 d. 23 Apr 1944
Odra Otis Nisley b. 14 Jul 1913 d. 26 Nov 1955
- 11 James Jackie Nisley [1.1.1.9.3.3.5.1.12.1.1]
b. 24 Jan 1940 d. 16 May 1970
Vesta Ruth Richey b. 29 Jul 1938 d. 4 Jul 2000
- 11 James Jackie Nisley [1.1.1.9.3.3.5.1.12.1.1]
- 10 Lowell Sylvester Atkins [1.1.1.9.3.3.5.1.12.2]
b. 28 Nov 1921 d. 23 Jan 1989
- + Evelyn Shiflet b. 23 May 1925 d. 28 Oct 2011
- + Evelyn Shiflet b. 23 May 1925 d. 28 Oct 2011
- 10 Chester Burton (Chet) Atkins [1.1.1.9.3.3.5.1.12.3]
b. 20 Jun 1924 d. 30 Jun 2001
Leona Johnson b. 12 Sep 1924 d. 21 Oct 2009
- 11 M. Atkins [1.1.1.9.3.3.5.1.12.3.1]
C. Sawyer
- 12 J.R. Sawyer [1.1.1.9.3.3.5.1.12.3.1.1]
[ =>]
- 12 J.R. Sawyer [1.1.1.9.3.3.5.1.12.3.1.1]
- 11 M. Atkins [1.1.1.9.3.3.5.1.12.3.1]
- 10 Nancy Niona Jane Atkins [1.1.1.9.3.3.5.1.12.1]
- + Ella May Archer b. 22 Apr 1894 d. 8 Aug 1915
- 9 Tilman Cornelius (Tim) Atkins [1.1.1.9.3.3.5.1.7]
- 8 Wesley Sylvestor Atkins [1.1.1.9.3.3.5.1]
- 7 Robert Rufus Atkins [1.1.1.9.3.3.6]
b. 16 Jan 1816 d. 17 Jan 1892
Pherebe Hill b. 17 Jun 1816 d. 18 Jan 1897
- 8 John Wesley Atkins [1.1.1.9.3.3.6.1]
b. 8 Mar 1838 d. 25 Jan 1883
- 8 Joseph Atkins [1.1.1.9.3.3.6.2]
b. 1840
- 8 Elizabeth Atkins [1.1.1.9.3.3.6.3]
b. 4 Feb 1840 d. 4 Nov 1886
- 8 Nancy A Atkins [1.1.1.9.3.3.6.4]
b. 1842 d. 1 May 1905
- 8 Lewis N Atkins [1.1.1.9.3.3.6.5]
b. 3 Sep 1843 d. 20 Jan 1892
- 8 Tyrissa Jane Adkins [1.1.1.9.3.3.6.6]
b. 1845
- 8 Elisha Atkins [1.1.1.9.3.3.6.7]
b. 1846
- 8 William F Adkins [1.1.1.9.3.3.6.8]
b. Abt 1846 d. Bef 1860
- 8 Adeline Atkins [1.1.1.9.3.3.6.9]
b. 30 May 1848 d. 3 Aug 1895
William George Monroe b. 25 Mar 1836 d. 2 Oct 1907
- 9 Horace Maynard Monroe [1.1.1.9.3.3.6.9.1]
b. 8 Sep 1861 d. 11 Dec 1936
Luzana Elizabeth Graves b. 5 Sep 1865 d. 3 Jan 1890
- 10 Ariebell Monroe [1.1.1.9.3.3.6.9.1.1]
b. 18 Jul 1885 d. 12 Jul 1966
- 10 William Preston Monroe [1.1.1.9.3.3.6.9.1.2]
b. 20 Nov 1886 d. 17 Oct 1940
Callie Isabelle Edmondson b. Abt 1891 d. 25 Jun 1964
- 11 Harmon Lawrence Monroe [1.1.1.9.3.3.6.9.1.2.1]
b. 9 Sep 1909 d. 11 Mar 1991
- 11 Walter Preston Monroe [1.1.1.9.3.3.6.9.1.2.2]
b. 30 May 1911 d. 25 Apr 1967
Vada E Lynch b. 1 Jul 1911 d. 23 Dec 1993
- 12 E. Monroe [1.1.1.9.3.3.6.9.1.2.2.1]
- 12 L.D. Monroe [1.1.1.9.3.3.6.9.1.2.2.2]
- 12 Charles Preston Monroe [1.1.1.9.3.3.6.9.1.2.2.3]
b. 7 Dec 1934 d. 7 Jul 1941
- 12 E. Monroe [1.1.1.9.3.3.6.9.1.2.2.1]
- 11 Vada Etta Monroe [1.1.1.9.3.3.6.9.1.2.3]
b. Abt 1912
Walter P Monroe b. Abt 1912
- 12 L.D. Monroe [1.1.1.9.3.3.6.9.1.2.3.1]
- 12 L.D. Monroe [1.1.1.9.3.3.6.9.1.2.3.1]
- 11 Irby Horace Monroe [1.1.1.9.3.3.6.9.1.2.4]
b. 7 Nov 1912 d. 11 Mar 1991
- 11 Jesse A Monroe [1.1.1.9.3.3.6.9.1.2.5]
b. Abt 1914
- 11 Harmon Lawrence Monroe [1.1.1.9.3.3.6.9.1.2.1]
- 10 Richard Sylvester Monroe, MD [1.1.1.9.3.3.6.9.1.3]
b. 6 Dec 1888 d. 6 Jan 1954
Ella Jane Ousley b. 26 Jun 1892 d. 18 Oct 1977
- 11 Leah Elizabeth Monroe [1.1.1.9.3.3.6.9.1.3.1]
b. 12 Oct 1914 d. 16 Dec 1981
William C Wolfe b. Abt 1908 d. Yes, date unknown
- 12 J.E. Wolfe [1.1.1.9.3.3.6.9.1.3.1.1]
- 12 J.E. Wolfe [1.1.1.9.3.3.6.9.1.3.1.1]
- 11 Eileen Monroe [1.1.1.9.3.3.6.9.1.3.2]
b. Abt 1917
- 11 Vauda Lee Monroe [1.1.1.9.3.3.6.9.1.3.3]
b. 14 Jun 1919 d. 30 Oct 2011
Charles H Needham b. 24 Jun 1920 d. 16 Aug 1993
- 12 D.C. Needham [1.1.1.9.3.3.6.9.1.3.3.1]
- 12 L.L. Needham [1.1.1.9.3.3.6.9.1.3.3.2]
- 12 D.C. Needham [1.1.1.9.3.3.6.9.1.3.3.1]
- 11 Leah Elizabeth Monroe [1.1.1.9.3.3.6.9.1.3.1]
- 10 Ariebell Monroe [1.1.1.9.3.3.6.9.1.1]
Mary J Gilbert b. 22 Jan 1871 d. 26 May 1939
- 10 Vadie Monroe [1.1.1.9.3.3.6.9.1.4]
b. Mar 1891 d. 23 Nov 1974
- 10 Iva Monroe [1.1.1.9.3.3.6.9.1.5]
b. Sep 1892
- 10 George Monroe [1.1.1.9.3.3.6.9.1.6]
b. 7 Nov 1893 d. Abt 1956
Pauline Victoria Birkenmeyer b. 13 May 1900 d. 12 Oct 1973
- 11 Harold J Monroe [1.1.1.9.3.3.6.9.1.6.1]
b. 6 Aug 27 d. 31 Jul 1999
- 11 K.P. Monroe [1.1.1.9.3.3.6.9.1.6.2]
- 11 M.M. Monroe [1.1.1.9.3.3.6.9.1.6.3]
- 11 Harold J Monroe [1.1.1.9.3.3.6.9.1.6.1]
- 10 James Monroe [1.1.1.9.3.3.6.9.1.7]
b. May 1895 d. 30 Dec 1968
- 10 Horace Oda Monroe [1.1.1.9.3.3.6.9.1.8]
b. 9 Jan 1898 d. 21 Mar 1978
Della Maude Sharp b. 28 Jan 1903 d. 22 Aug 1983
- 11 Naomi Monroe [1.1.1.9.3.3.6.9.1.8.1]
b. 13 Feb 1919 d. 9 Dec 2009
Richard Pettiebone Campbell, Jr b. 26 Oct 1914 d. 29 May 1995
- 12 R.G. Campbell [1.1.1.9.3.3.6.9.1.8.1.1]
- 12 Gloria Faye Campbell [1.1.1.9.3.3.6.9.1.8.1.2]
b. 4 Feb 1942 d. 22 Jan 2014
- 12 J. Campbell [1.1.1.9.3.3.6.9.1.8.1.3]
- 12 R. Campbell [1.1.1.9.3.3.6.9.1.8.1.4]
- 12 R.G. Campbell [1.1.1.9.3.3.6.9.1.8.1.1]
- 11 Roy Parks Monroe [1.1.1.9.3.3.6.9.1.8.2]
b. 23 Apr 1920 d. 14 May 1996
- 11 Sarah Frances Monroe [1.1.1.9.3.3.6.9.1.8.3]
b. 16 Mar 1928 d. 31 Aug 2017
- 11 Naomi Monroe [1.1.1.9.3.3.6.9.1.8.1]
- 10 Biddie Monroe [1.1.1.9.3.3.6.9.1.9]
b. 23 Jun 1907 d. 24 Jul 1983
- + Wyrick
- + Wyrick
- 10 Ica Scates Monroe [1.1.1.9.3.3.6.9.1.10]
b. 23 Jun 1907 d. 1 Apr 1951
Coy E Sharp b. 1909 d. 1975
- 10 Vadie Monroe [1.1.1.9.3.3.6.9.1.4]
- 9 Mary Etter Monroe [1.1.1.9.3.3.6.9.2]
b. 21 Feb 1868 d. 26 Feb 1926
- 9 Elizabeth Monroe [1.1.1.9.3.3.6.9.3]
b. 25 Feb 1870 d. 25 Mar 1901
- 9 Eugene Dodge Monroe [1.1.1.9.3.3.6.9.4]
b. 27 Apr 1872 d. 8 Oct 1937
- 9 Minnie Warren Monroe [1.1.1.9.3.3.6.9.5]
b. 2 Aug 1874 d. 13 Dec 1972
- 9 James L Monroe [1.1.1.9.3.3.6.9.6]
b. 23 Jun 1877 d. 23 Sep 1936
- 9 Lillian L Monroe [1.1.1.9.3.3.6.9.7]
b. 30 Sep 1880 d. 12 May 1973
- 9 Robert Thornburgh Monroe [1.1.1.9.3.3.6.9.8]
b. 29 Mar 1884 d. Nov 1929
Bertha L Butcher b. 1886
- 10 Cleda Alpha Monroe [1.1.1.9.3.3.6.9.8.1]
b. 9 Feb 1907 d. 14 Mar 1995
- 10 Claude La Vaughn Monroe [1.1.1.9.3.3.6.9.8.2]
b. 11 Jul 1909
- 10 Cleda Alpha Monroe [1.1.1.9.3.3.6.9.8.1]
- 9 Alice Monroe [1.1.1.9.3.3.6.9.9]
b. 25 Jan 1887 d. 24 Jan 1888
- 9 Milton Tecumseh Monroe [1.1.1.9.3.3.6.9.10]
b. 18 Apr 1889 d. 13 Aug 1946
- 9 Horace Maynard Monroe [1.1.1.9.3.3.6.9.1]
- 8 Emeline Atkins [1.1.1.9.3.3.6.10]
b. 1849 d. 1878
- 8 John Wesley Atkins [1.1.1.9.3.3.6.1]
- 7 Elizabeth Atkins [1.1.1.9.3.3.7]
b. 17 Jan 1819 d. Aft 1856
James Hubbs b. 1824 d. May 1880
- 8 Fanny Hubbs [1.1.1.9.3.3.7.1]
b. Abt 1849
- 8 Maynard M Hubbs [1.1.1.9.3.3.7.2]
b. 12 Dec 1853 d. 9 Aug 1929
- 8 Thursey Ann Hubbs [1.1.1.9.3.3.7.3]
b. 15 Feb 1854 d. 20 Sep 1938
- 8 Margaret Hubbs [1.1.1.9.3.3.7.4]
b. Abt 1855
- 8 James C Hubbs [1.1.1.9.3.3.7.5]
b. 21 Mar 1859 d. 15 Jul 1888
- 8 Malinda Emmaline Hubbs [1.1.1.9.3.3.7.6]
b. 10 Aug 1861 d. 18 May 1941
- 8 Fanny Hubbs [1.1.1.9.3.3.7.1]
- 7 Mary (Polly) Atkins [1.1.1.9.3.3.8]
b. 17 May 1821 d. Aft 1845
- + John Burnett b. 1812
- + John Burnett b. 1812
- 7 Rachel Atkins [1.1.1.9.3.3.9]
b. 30 Apr 1826 d. 1848
James M Hubbs b. 1824 d. May 1880
- 8 Lewis Hubbs [1.1.1.9.3.3.9.1]
b. Abt 1847 d. Bef 1860
- 8 Rachel Hubbs [1.1.1.9.3.3.9.2]
b. Abt 1848 d. Abt 1871
- 8 Lewis Hubbs [1.1.1.9.3.3.9.1]
- 7 Lewis Atkins, Jr [1.1.1.9.3.3.10]
b. 26 Sep 1828 d. 10 Mar 1904
- + Elizabeth Jane Atkins b. 26 Jul 1832 d. 8 Mar 1922
- + Elizabeth Jane Atkins b. 26 Jul 1832 d. 8 Mar 1922
- 7 Luretta Adkins [1.1.1.9.3.3.11]
b. 1835
- 7 Ira Atkins, I [1.1.1.9.3.3.12]
b. 1837
- 7 Margaret Atkins [1.1.1.9.3.3.1]
- 6 John Monroe [1.1.1.9.3.4]
b. 1786 d. 1860
A.E. Wyrick
- 7 L. Monroe [1.1.1.9.3.4.1]
- 7 R. Monroe [1.1.1.9.3.4.2]
- 7 Pryor L Monroe [1.1.1.9.3.4.3]
b. Abt 1824
- 7 L. Monroe [1.1.1.9.3.4.1]
- 6 Robert Monroe, Jr [1.1.1.9.3.5]
b. 1791 d. 1847
Sarah Sally Burnett b. 1807 d. 1851
- 7 Elisha Monroe [1.1.1.9.3.5.1]
b. 1829 d. 3 Nov 1891
- 7 Calloway Monroe [1.1.1.9.3.5.2]
b. 30 Aug 1831 d. Bef 1870
Sarah Warwick b. 25 Jan 1830 d. 30 May 1897
- 8 Harvey Leroy Monroe [1.1.1.9.3.5.2.1]
b. 6 May 1854 d. 27 Jan 1924
- 8 Perley Jane Monroe [1.1.1.9.3.5.2.2]
b. 1858 d. 19 Oct 1896
- 8 Nancy Frances Monroe [1.1.1.9.3.5.2.3]
b. 1859 d. 6 Jan 1932
- 8 Mary Etter Monroe [1.1.1.9.3.5.2.4]
b. 27 Feb 1860
- 8 William C Monroe [1.1.1.9.3.5.2.5]
b. 1864 d. 16 Feb 1883
- 8 Harvey Leroy Monroe [1.1.1.9.3.5.2.1]
- 7 Enoch Monroe [1.1.1.9.3.5.3]
b. 1833 d. Bef 1880
Elizabeth Graves b. Jun 1832 d. Feb 1904
- 8 Martha J Monroe [1.1.1.9.3.5.3.1]
b. Abt 1859
- 8 Emily Monroe [1.1.1.9.3.5.3.2]
b. Abt 1860
- 8 Tilghman H Monroe [1.1.1.9.3.5.3.3]
b. Abt 1862
- 8 Pearlina Monroe [1.1.1.9.3.5.3.4]
b. Abt 1868
- 8 Barbery Monroe [1.1.1.9.3.5.3.5]
b. Abt 1869
- 8 Ellen Monroe [1.1.1.9.3.5.3.6]
b. Feb 1870 d. 8 Feb 1944
- 8 Martha J Monroe [1.1.1.9.3.5.3.1]
- 7 George Monroe [1.1.1.9.3.5.4]
b. Jun 1834 d. 7 Nov 1913
- 7 Alexander Monroe [1.1.1.9.3.5.5]
b. 1836 d. 1858
- 7 Nathaniel Monroe [1.1.1.9.3.5.6]
b. 1840 d. 17 Jun 1920
- 7 James Henry Monroe [1.1.1.9.3.5.7]
b. 13 Feb 1848 d. 5 Jul 1931
- 7 Elisha Monroe [1.1.1.9.3.5.1]
- 6 Margaret Monroe [1.1.1.9.3.6]
b. 1791 d. 11 Feb 1834
John Wyrick b. 2 Feb 1751
- 7 Jefferson Wyrick [1.1.1.9.3.6.1]
b. 1 Aug 1811
- 7 Jefferson Wyrick [1.1.1.9.3.6.1]
- 6 Barbara Margaret Monroe [1.1.1.9.3.7]
b. 1792 d. 22 Feb 1866
John Kitts b. 1788 d. 7 Oct 1850
- 7 Davidson Kitts [1.1.1.9.3.7.1]
b. 9 Jul 1812 d. 4 Apr 1899
- 7 Solomon Temple Kitts [1.1.1.9.3.7.2]
b. 1813 d. 1880
- 7 Robert Kitts [1.1.1.9.3.7.3]
b. 1816 d. 1880
- 7 Rosanna Kitts [1.1.1.9.3.7.4]
b. Abt 1817
- 7 Margaret Kitts [1.1.1.9.3.7.5]
b. Abt 1818 d. 26 Nov 1879
- 7 Henry Kitts [1.1.1.9.3.7.6]
b. 1822 d. 14 Apr 1916
- 7 Mark Kitts [1.1.1.9.3.7.7]
b. 1823 d. 16 Jun 1863
Margaret A Seviers b. 15 Feb 1824 d. 29 Apr 1905
- 8 Joseph Filmore Kitts [1.1.1.9.3.7.7.1]
b. 28 Oct 1852 d. 25 Mar 1925
Sarah E Price b. 13 Aug 1853 d. 18 Feb 1898
- 9 Margaret Jane Kitts [1.1.1.9.3.7.7.1.1]
b. 16 Oct 1874 d. 14 Oct 1956
- 9 Mary Paralee Kitts [1.1.1.9.3.7.7.1.2]
b. 1878 d. 3 May 1944
- 9 Perlina E Kitts [1.1.1.9.3.7.7.1.3]
b. 21 Jun 1879 d. 27 Aug 1972
- 9 Moses Roy Kitts [1.1.1.9.3.7.7.1.4]
b. 12 Oct 1881 d. 30 Aug 1972
- 9 Nancy Lottie Kitts [1.1.1.9.3.7.7.1.5]
b. 12 Nov 1883 d. 21 Feb 1971
- 9 Victor Hugo Kitts [1.1.1.9.3.7.7.1.6]
b. 26 Feb 1889 d. 21 Sep 1980
- 9 Anna Kitts [1.1.1.9.3.7.7.1.7]
b. 3 Mar 1892 d. 16 May 1919
- 9 Robert J Kitts [1.1.1.9.3.7.7.1.8]
b. 30 Apr 1894 d. 8 Nov 1985
Carrie M Popejoy b. 11 Jan 1893 d. 24 Dec 1955
- 10 Carl Ray Kitts [1.1.1.9.3.7.7.1.8.1]
b. 1919 d. 1987
- + Tilda Belle Satterfield b. 17 Aug 1927 d. 7 Jan 2012
- + Tilda Belle Satterfield b. 17 Aug 1927 d. 7 Jan 2012
- 10 Carl Ray Kitts [1.1.1.9.3.7.7.1.8.1]
- 9 Margaret Jane Kitts [1.1.1.9.3.7.7.1.1]
Maude L Cardwell b. 21 Sep 1888 d. 10 Dec 1940
- 9 Q. Kitts [1.1.1.9.3.7.7.1.9]
- 9 J. Kitts [1.1.1.9.3.7.7.1.10]
- 9 Joseph Filmore Kitts, Jr [1.1.1.9.3.7.7.1.11]
b. 7 Feb 1868 d. 14 Feb 1951
- 9 Roster Hoyt Kitts [1.1.1.9.3.7.7.1.12]
b. 12 Jun 1907 d. 12 Mar 1926
- 9 Lula Kitts [1.1.1.9.3.7.7.1.13]
b. 14 Aug 1908 d. 7 May 1935
- 9 Bonnie Kate Kitts [1.1.1.9.3.7.7.1.14]
b. Abt 1912 d. 3 Jun 2007
- 9 Hollis Gray Kitts, Sr [1.1.1.9.3.7.7.1.15]
b. 17 Nov 1914 d. 21 Oct 1992
Edith Hope Raley b. 31 Mar 1922 d. 8 Apr 2016
- 10 M. Kitts [1.1.1.9.3.7.7.1.15.1]
- 10 John Robert Kitts [1.1.1.9.3.7.7.1.15.2]
b. 18 Apr 1943 d. 24 Nov 2008
- 10 J.H. Kitts [1.1.1.9.3.7.7.1.15.3]
- 10 A.K. Kitts [1.1.1.9.3.7.7.1.15.4]
C.T. Fields
- 11 T. Fields [1.1.1.9.3.7.7.1.15.4.1]
- 11 T. Fields [1.1.1.9.3.7.7.1.15.4.1]
- 10 Hollis Gray Kitts, Jr [1.1.1.9.3.7.7.1.15.5]
b. 24 Nov 1948 d. 23 Dec 1976
- 10 M. Kitts [1.1.1.9.3.7.7.1.15.1]
- 9 Pearl Kitts [1.1.1.9.3.7.7.1.16]
b. Abt 1918
- 9 Ruth M Kitts [1.1.1.9.3.7.7.1.17]
b. 22 Jul 1924 d. 21 Oct 2004
- 9 Q. Kitts [1.1.1.9.3.7.7.1.9]
- 8 Barbara Carolyn Kitts [1.1.1.9.3.7.7.2]
b. Jul 1856 d. 1920
- 8 Hansel Menyard Kitts [1.1.1.9.3.7.7.3]
b. 1860 d. 1910
- 8 Solomon Temple Kitts [1.1.1.9.3.7.7.4]
b. 13 Aug 1860 d. 19 Mar 1911
- 8 Joseph Filmore Kitts [1.1.1.9.3.7.7.1]
- 7 Isaac Kitts [1.1.1.9.3.7.8]
b. 1824 d. 1860
- 7 Joseph Wheeler Kitts [1.1.1.9.3.7.9]
b. 5 Jun 1825 d. 1880
- 7 John C Kitts [1.1.1.9.3.7.10]
b. 1826 d. 1924
- 7 George Mark Kitts [1.1.1.9.3.7.11]
b. 1828 d. 12 Jun 1863
- 7 Dicey Ellen Kitts [1.1.1.9.3.7.12]
b. 1829 d. 6 Mar 1946
- 7 Andrew George Kitts [1.1.1.9.3.7.13]
b. 1830 d. 16 Jun 1863
- 7 Edward Caswell Kitts [1.1.1.9.3.7.14]
b. Jan 1834 d. 24 Mar 1924
Margaret Susan Colvin b. Mar 1834 d. Nov 1910
- 8 Martha Kitts [1.1.1.9.3.7.14.1]
b. 1853
- 8 Barbara Ann Kitts [1.1.1.9.3.7.14.2]
b. 4 Nov 1857 d. 1 Feb 1931
- 8 Lucinda Jane Kitts [1.1.1.9.3.7.14.3]
b. 1859
- 8 Cordelia Cinthia Kitts [1.1.1.9.3.7.14.4]
b. 29 May 1860 d. 19 Apr 1880
- 8 Martha Kitts [1.1.1.9.3.7.14.1]
- 7 Sterling Huston Kitts [1.1.1.9.3.7.15]
b. 10 Jul 1835 d. 20 Mar 1924
- 7 Polly Kitts [1.1.1.9.3.7.16]
b. 1845
- 7 Davidson Kitts [1.1.1.9.3.7.1]
- 6 Marcus Monroe [1.1.1.9.3.8]
b. 3 Aug 1793 d. 6 Sep 1870
Nancy Davis b. 14 Jul 1795 d. 8 Aug 1853
- 7 Lea Anderson Monroe [1.1.1.9.3.8.1]
b. 13 May 1815 d. 1887
Nancy Atkins b. 4 Apr 1815 d. 14 Jun 1889
- 8 Mark M Monroe [1.1.1.9.3.8.1.1]
b. 28 May 1835 d. 19 Jan 1918
Lurette Adkins b. Abt 1835 d. Bef 1910
- 9 Anna Cordia Monroe [1.1.1.9.3.8.1.1.1]
b. 2 Dec 1854 d. 9 Jan 1932
- 9 Eldridge Monroe [1.1.1.9.3.8.1.1.2]
b. Abt 1857 d. 14 Apr 1950
Amelia Rucker b. 24 May 1857 d. 20 Jun 1936
- 10 Tolbert Prailo Monroe [1.1.1.9.3.8.1.1.2.1]
b. 11 Mar 1885 d. 9 May 1951
Lyda Grace Needham b. 18 May 1885 d. 26 Sep 1970
- 11 Weir Lee Monroe, Sr [1.1.1.9.3.8.1.1.2.1.1]
b. 28 Dec 1904 d. 4 Apr 1997
Estella Corrina Booker b. 20 Jun 1896 d. 31 Aug 1973
- 12 Frances V Monroe [1.1.1.9.3.8.1.1.2.1.1.1]
b. 31 Mar 1925 d. 8 Oct 1990
- 12 Weir Lee Monroe, Jr [1.1.1.9.3.8.1.1.2.1.1.2]
b. 15 Feb 1929 d. 22 Apr 1996 [ =>]
- 12 Morris Hall Monroe, Sr [1.1.1.9.3.8.1.1.2.1.1.3]
b. 7 May 1930 d. 13 Feb 1985
- 12 Frances V Monroe [1.1.1.9.3.8.1.1.2.1.1.1]
- 11 Calma Vaughn Monroe [1.1.1.9.3.8.1.1.2.1.2]
b. 2 May 1916 d. 19 Aug 1999
Hazel C Vandergriff b. 11 Jun 1917 d. 21 Jul 1963
- 12 Harl Lee Monroe [1.1.1.9.3.8.1.1.2.1.2.1]
b. 6 Jun 1939 d. 5 Mar 2015
- 12 L. Monroe [1.1.1.9.3.8.1.1.2.1.2.2]
- 12 Brenda Faye Monroe [1.1.1.9.3.8.1.1.2.1.2.3]
b. 7 Feb 1950 d. 3 Jun 2014
- 12 Harl Lee Monroe [1.1.1.9.3.8.1.1.2.1.2.1]
- + Sara Elizabeth Clement b. 1 Nov 1918 d. 20 Sep 1998
- 11 Frances Maud Monroe [1.1.1.9.3.8.1.1.2.1.3]
b. 25 Nov 1918 d. 10 Sep 1922
- 11 Edna Lucile Monroe [1.1.1.9.3.8.1.1.2.1.4]
b. 4 May 1921 d. 2 Feb 2015
- + Pryor Lee Acuff b. 5 Mar 1908 d. 19 Jan 1998
- + Pryor Lee Acuff b. 5 Mar 1908 d. 19 Jan 1998
- 11 Weir Lee Monroe, Sr [1.1.1.9.3.8.1.1.2.1.1]
- 10 Tolbert Prailo Monroe [1.1.1.9.3.8.1.1.2.1]
- 9 Anna Cordia Monroe [1.1.1.9.3.8.1.1.1]
Sarah Harrison b. Abt 1850 d. 16 Sep 1882
- 9 Arlee G Monroe [1.1.1.9.3.8.1.1.3]
b. Apr 1867 d. 1947
- 9 Vilance Monroe [1.1.1.9.3.8.1.1.4]
b. 1874
- 9 Mary Etta Monroe [1.1.1.9.3.8.1.1.5]
b. 30 May 1874
- 9 Matilda Roberta Monroe [1.1.1.9.3.8.1.1.6]
b. Nov 1879 d. 25 Nov 1968
- 9 Arlee G Monroe [1.1.1.9.3.8.1.1.3]
Nancy E Dyer b. 2 Oct 1849 d. 10 Mar 1889
- 9 Amanda Tennessee Monroe [1.1.1.9.3.8.1.1.7]
b. 11 Oct 1884 d. 21 Jan 1891
- 9 Amanda Tennessee Monroe [1.1.1.9.3.8.1.1.7]
Emily Jones b. Abt 1860 d. 5 Jul 1920
- 9 Horace Leonard Monroe [1.1.1.9.3.8.1.1.8]
b. 5 Jun 1890 d. Sep 1970
- 9 Horace Leonard Monroe [1.1.1.9.3.8.1.1.8]
- 8 Margaret Monroe [1.1.1.9.3.8.1.2]
b. 1838 d. 11 Aug 1904
- 8 Martin V Monroe [1.1.1.9.3.8.1.3]
b. Aug 1838 d. 24 Oct 1914
- 8 Louisa Jane Monroe [1.1.1.9.3.8.1.4]
b. 17 Jun 1839 d. 18 Aug 1913
Thomas Brooks McMillin b. 19 Jul 1834 d. 7 Dec 1864
- 9 James Morgan McMillin [1.1.1.9.3.8.1.4.1]
b. 1 Jul 1859 d. 31 Aug 1934
Mary Frances Leslie b. 9 Feb 1862 d. 19 Nov 1920
- 10 Oscar Oren McMillin [1.1.1.9.3.8.1.4.1.1]
b. 16 May 1884 d. 9 Mar 1942
Elva May Roark b. 1 May 1884 d. 14 Mar 1979
- 11 Infant McMillin [1.1.1.9.3.8.1.4.1.1.1]
b. 22 Aug 1910 d. 22 Aug 1910
- 11 Leslie Oren McMillin [1.1.1.9.3.8.1.4.1.1.2]
b. 12 Dec 1918 d. 28 May 1988
Dorothy Louise Feasel b. 5 Nov 1922 d. 13 Nov 1992
- 12 D.L. McMillin [1.1.1.9.3.8.1.4.1.1.2.1]
- 12 Leslie Anne McMillin [1.1.1.9.3.8.1.4.1.1.2.2]
b. 4 Feb 1946 d. 3 Feb 2004
- 12 D.L. McMillin [1.1.1.9.3.8.1.4.1.1.2.1]
- 11 Infant McMillin [1.1.1.9.3.8.1.4.1.1.1]
- 10 Ethel Grace McMillin [1.1.1.9.3.8.1.4.1.2]
b. 23 Jan 1888 d. 18 May 1911
- 10 Lester Brooks McMillin [1.1.1.9.3.8.1.4.1.3]
b. 19 Sep 1890 d. 2 Nov 1977
- 10 John Leslie McMillin [1.1.1.9.3.8.1.4.1.4]
b. 3 May 1894 d. 4 Dec 1931
Bessie Olive McDonald b. 14 Oct 1890 d. 29 Sep 1977
- 11 Charles Herbert McMillin [1.1.1.9.3.8.1.4.1.4.1]
b. 12 May 1927 d. 26 Feb 1994
- 11 Charles Herbert McMillin [1.1.1.9.3.8.1.4.1.4.1]
- 10 Alice Rella McMillin [1.1.1.9.3.8.1.4.1.5]
b. 14 Apr 1896 d. 28 May 1984
- 10 Virgie Fonso McMillin [1.1.1.9.3.8.1.4.1.6]
b. 20 Apr 1898 d. 10 Jan 1936
Levi Edward Saylor b. 4 Nov 1904 d. 23 Jul 1984
- 11 Frances Katherine Saylor [1.1.1.9.3.8.1.4.1.6.1]
b. 24 Jan 1933 d. 20 Apr 1962
David Edward Hauf, Sr b. 11 Dec 1928 d. 30 Apr 1962
- 12 Debra Dianne Hauf [1.1.1.9.3.8.1.4.1.6.1.1]
b. 6 Dec 1951 d. 20 Apr 1962
- 12 David Edward Hauf, Jr [1.1.1.9.3.8.1.4.1.6.1.2]
b. 20 Aug 1959 d. 20 Apr 1962
- 12 Debra Dianne Hauf [1.1.1.9.3.8.1.4.1.6.1.1]
- 11 Virgil Lee Saylor [1.1.1.9.3.8.1.4.1.6.2]
b. 2 Jan 1936 d. 14 Feb 1936
- 11 Frances Katherine Saylor [1.1.1.9.3.8.1.4.1.6.1]
- 10 Charles B McMillin [1.1.1.9.3.8.1.4.1.7]
b. 17 Mar 1900 d. 21 Jul 1902
- 10 Floyd Elza McMillin [1.1.1.9.3.8.1.4.1.8]
b. 28 Jun 1902 d. 10 Jul 1968
- + Ruth Mildred Long b. 25 Mar 1905 d. 11 Dec 2001
- + Ruth Mildred Long b. 25 Mar 1905 d. 11 Dec 2001
- 10 Audrey Lorene McMillin [1.1.1.9.3.8.1.4.1.9]
b. 13 Sep 1905 d. 4 Sep 1979
- + Carlos Russell Ellis b. 20 Sep 1900 d. 19 Apr 1992
- + Carlos Russell Ellis b. 20 Sep 1900 d. 19 Apr 1992
- 10 Oscar Oren McMillin [1.1.1.9.3.8.1.4.1.1]
- 9 Infant McMillin [1.1.1.9.3.8.1.4.2]
b. 3 Mar 1863 d. 22 Feb 1864
- 9 James Morgan McMillin [1.1.1.9.3.8.1.4.1]
Noah Roark b. 13 Jun 1832 d. 11 Mar 1898
- 9 Rella Randolph Roark [1.1.1.9.3.8.1.4.3]
b. 5 Dec 1867 d. 15 Nov 1966
Daniel Webster Son b. 1 Jan 1865 d. 9 Jul 1955
- 10 Alma Jane (Munna) Son [1.1.1.9.3.8.1.4.3.1]
b. 28 Mar 1891 d. 2 Feb 1983
Francis Moore (Mode) Milburn b. 25 May 1883 d. 1 Jan 1975
- 11 Daniel Judson Milburn [1.1.1.9.3.8.1.4.3.1.1]
b. 17 Feb 1913 d. 26 Aug 2000
Vera Pritchard b. Abt 1917
- 12 M.K. Milburn [1.1.1.9.3.8.1.4.3.1.1.1]
- 12 I.M. Milburn [1.1.1.9.3.8.1.4.3.1.1.2]
- 12 M.K. Milburn [1.1.1.9.3.8.1.4.3.1.1.1]
- 11 Donald Wyeth Milburn [1.1.1.9.3.8.1.4.3.1.2]
b. 7 Sep 1914 d. 20 May 2000
Mary Elizabeth Myers b. Abt 1916
- 12 R.L. Melburn [1.1.1.9.3.8.1.4.3.1.2.1]
- 12 M. Melburn [1.1.1.9.3.8.1.4.3.1.2.2]
- 12 J. Melburn [1.1.1.9.3.8.1.4.3.1.2.3]
- 12 R.L. Melburn [1.1.1.9.3.8.1.4.3.1.2.1]
- 11 Nell Milburn [1.1.1.9.3.8.1.4.3.1.3]
b. 16 Apr 1916 d. 19 Nov 2005
- 11 Eloise M Milburn [1.1.1.9.3.8.1.4.3.1.4]
b. 21 Jul 1918 d. 21 Jun 2008
William Ramsey Harris b. 28 Jun 1915 d. 21 Jan 2008
- 12 K.H. Harris [1.1.1.9.3.8.1.4.3.1.4.1]
- 12 W.R. Harris, Jr [1.1.1.9.3.8.1.4.3.1.4.2]
- 12 D.M. Harris [1.1.1.9.3.8.1.4.3.1.4.3]
- 12 K.H. Harris [1.1.1.9.3.8.1.4.3.1.4.1]
- 11 June M Milburn [1.1.1.9.3.8.1.4.3.1.5]
b. 16 Jun 1920 d. 7 Jun 2019
Sigfrid Emanuel Floren, Jr b. 3 Jul 1919 d. 20 Jan 1980
- 12 C.M. Floren [1.1.1.9.3.8.1.4.3.1.5.1]
- 12 C.M. Floren [1.1.1.9.3.8.1.4.3.1.5.1]
- 11 Mode Wayne Milburn [1.1.1.9.3.8.1.4.3.1.6]
b. 15 Apr 1922 d. 19 Jun 1982
- 11 Daniel Judson Milburn [1.1.1.9.3.8.1.4.3.1.1]
- 10 Ruth Son [1.1.1.9.3.8.1.4.3.2]
b. 16 Sep 1892 d. 26 Jun 1984
Elbert Paul Powell b. 8 Mar 1883 d. 1952
- 11 Paul Thurston Powell [1.1.1.9.3.8.1.4.3.2.1]
b. 9 Dec 1914 d. 1 Jul 1988
Lucille Elaine Hinshaw b. 17 Aug 1917 d. 22 Feb 1993
- 12 P. Powell [1.1.1.9.3.8.1.4.3.2.1.1]
[ =>]
- 12 Paul Hinshaw Powell [1.1.1.9.3.8.1.4.3.2.1.2]
b. 2 Sep 1945 d. 25 Mar 2013
- 12 Phillip Raymond Powell [1.1.1.9.3.8.1.4.3.2.1.3]
b. 24 Jun 1948 d. 19 Nov 2020 [ =>]
- 12 P. Powell [1.1.1.9.3.8.1.4.3.2.1.1]
- 11 Glenn Dorris Powell [1.1.1.9.3.8.1.4.3.2.2]
b. Abt 1917
- 11 Paul Thurston Powell [1.1.1.9.3.8.1.4.3.2.1]
- 10 Daniel Randolph (Dolph) Son [1.1.1.9.3.8.1.4.3.3]
b. 6 May 1894 d. 21 Oct 1969
Sally Belinda O'dell b. Abt 1899
- 11 James Daniel Son [1.1.1.9.3.8.1.4.3.3.1]
b. 2 Mar 1916 d. 6 Jun 1985
- 11 Geraldine J Son [1.1.1.9.3.8.1.4.3.3.2]
b. 10 Apr 1918 d. 4 Feb 2005
Glen Alvin Triplitt b. 8 Sep 1915 d. 28 Jul 1993
- 12 Daniel Glenn Triplitt [1.1.1.9.3.8.1.4.3.3.2.1]
b. 5 Aug 1939 d. 4 May 1970
- 12 Daniel Glenn Triplitt [1.1.1.9.3.8.1.4.3.3.2.1]
- 11 James Daniel Son [1.1.1.9.3.8.1.4.3.3.1]
- + Alice Lindell Peacock b. Abt 1899 d. 7 Feb 1970
- 10 Ireta Son [1.1.1.9.3.8.1.4.3.4]
b. 9 Feb 1896 d. 1 Feb 1983
Arthur Clifton Jacks b. 29 Aug 1893 d. 21 May 1968
- 11 Rella Anne Jacks [1.1.1.9.3.8.1.4.3.4.1]
b. 30 Apr 1922 d. 29 Mar 2018
- 11 Dorothy Jane Jacks [1.1.1.9.3.8.1.4.3.4.2]
b. Abt 1924 d. 20 Nov 2015
- 11 Lajoy Jacks [1.1.1.9.3.8.1.4.3.4.3]
b. 29 Aug 1927 d. 10 Mar 1989
- 11 Rella Anne Jacks [1.1.1.9.3.8.1.4.3.4.1]
- + Carl Clifford Creamer b. 29 Jul 1896 d. 10 Sep 1956
- 10 Noah Malcolm Son [1.1.1.9.3.8.1.4.3.5]
b. 24 Nov 1897 d. 30 Jul 1990
Emma Milburn b. 3 Oct 1897 d. 20 Jul 1968
- 11 Noah Dean Son [1.1.1.9.3.8.1.4.3.5.1]
b. 7 Jul 1920 d. 23 Feb 1996
- 11 Neysa Son [1.1.1.9.3.8.1.4.3.5.2]
b. 1 Jun 1923 d. 12 Feb 2017
N. Shires
- 12 M. Shires [1.1.1.9.3.8.1.4.3.5.2.1]
- 12 M. Shires [1.1.1.9.3.8.1.4.3.5.2.1]
- + Luther Lee Lively b. 21 Sep 1917 d. 8 Jan 2009
David Neyland Compton
- 12 D.N. Compton, II [1.1.1.9.3.8.1.4.3.5.2.2]
- 12 D.N. Compton, II [1.1.1.9.3.8.1.4.3.5.2.2]
- 11 James Howell Son [1.1.1.9.3.8.1.4.3.5.3]
b. 28 May 1925 d. 7 Aug 2018
Verna Beth Eddins b. 27 Nov 1925 d. 26 Jul 2016
- 11 Sue Ellen Son [1.1.1.9.3.8.1.4.3.5.4]
b. 7 Aug 1927 d. 3 Sep 2019
- + William Byron Billman b. 5 Jan 1921 d. 1 Oct 2006
- + William Byron Billman b. 5 Jan 1921 d. 1 Oct 2006
- 11 Noah Dean Son [1.1.1.9.3.8.1.4.3.5.1]
- 10 Mountan Son [1.1.1.9.3.8.1.4.3.6]
b. Abt 1899
- 10 James Aubrey Son [1.1.1.9.3.8.1.4.3.7]
b. 24 Oct 1900 d. 17 Aug 1972
- + Carrie M Murrell b. 3 Mar 1900 d. 15 Jan 1974
- + Carrie M Murrell b. 3 Mar 1900 d. 15 Jan 1974
- 10 Orbra J Son [1.1.1.9.3.8.1.4.3.8]
b. Abt 1901 d. 17 Aug 1972
- 10 Bessica Son [1.1.1.9.3.8.1.4.3.9]
b. 24 Oct 1902 d. 4 Apr 1987
Perry Phillip Britten b. 18 Jan 1905 d. 4 Mar 1981
- 11 D. Britten [1.1.1.9.3.8.1.4.3.9.1]
- 11 J. Britten [1.1.1.9.3.8.1.4.3.9.2]
- 11 D. Britten [1.1.1.9.3.8.1.4.3.9.1]
- 10 John Webster Son [1.1.1.9.3.8.1.4.3.10]
b. 31 Mar 1906 d. 23 Nov 1987
- + Bertha Edna Clayton b. 29 Jan 1910 d. 23 Apr 2005
- + Bertha Edna Clayton b. 29 Jan 1910 d. 23 Apr 2005
- 10 Alma Jane (Munna) Son [1.1.1.9.3.8.1.4.3.1]
- 9 William Monroe Roark [1.1.1.9.3.8.1.4.4]
b. 17 Dec 1873 d. 12 Apr 1926
- 9 Rella Randolph Roark [1.1.1.9.3.8.1.4.3]
- 8 Mary Addie Monroe [1.1.1.9.3.8.1.5]
b. 1842 d. Between 1843 and 1936
- 8 James Calvin Monroe [1.1.1.9.3.8.1.6]
b. 21 Apr 1844 d. 9 Jan 1909
Mary Ann Shadwick b. 11 Feb 1853 d. 14 May 1947
- 9 Alfred Edwin Monroe, MD [1.1.1.9.3.8.1.6.1]
b. 10 Apr 1870 d. 30 Jun 1954
Sarah Frances Hill b. 11 Mar 1874 d. 3 May 1951
- 10 Edith Lucille Monroe [1.1.1.9.3.8.1.6.1.1]
b. 12 Nov 1897 d. 15 Nov 1961
William Dresel Cunningham b. 16 Oct 1898 d. 17 Sep 1983
- 11 Billy Jean Cunningham [1.1.1.9.3.8.1.6.1.1.1]
b. 25 Jul 1922 d. 14 Jun 2010
Paul Alvin Nesselroad b. 9 Aug 1921 d. 25 Aug 1973
- 12 P.E. Nesselroad [1.1.1.9.3.8.1.6.1.1.1.1]
- 12 P.K. Nesselroad [1.1.1.9.3.8.1.6.1.1.1.2]
- 12 N.A. Nesselroad [1.1.1.9.3.8.1.6.1.1.1.3]
- 12 P.E. Nesselroad [1.1.1.9.3.8.1.6.1.1.1.1]
- + Donald John Vinson b. 29 Feb 1920 d. 5 Jan 2011
- 11 Billy Jean Cunningham [1.1.1.9.3.8.1.6.1.1.1]
- 10 Edith Lucille Monroe [1.1.1.9.3.8.1.6.1.1]
- 9 Nevada Elizabeth Monroe [1.1.1.9.3.8.1.6.2]
b. 5 Aug 1872 d. 1 Apr 1947
- + Lucian C Wilkerson b. 20 Apr 1871 d. 29 Mar 1957
- + Lucian C Wilkerson b. 20 Apr 1871 d. 29 Mar 1957
- 9 Mary Melcenia Monroe [1.1.1.9.3.8.1.6.3]
b. 27 Sep 1875 d. 16 Mar 1949
John Louis Morrow b. Feb 1867 d. 6 Jan 1930
- 10 Undrie Richard Morrow [1.1.1.9.3.8.1.6.3.1]
b. 30 Oct 1894 d. 4 May 1896
- 10 Hubert Orion Morrow [1.1.1.9.3.8.1.6.3.2]
b. 30 Jun 1898 d. 3 Nov 1978
Lula E Lurton b. 22 Mar 1898 d. 15 Feb 1989
- 11 Jack Morrow [1.1.1.9.3.8.1.6.3.2.1]
b. 26 Nov 1916 d. 22 Jul 2000
Jane Francis Kenney b. 7 Jan 1918 d. Jun 1994
- 12 M.J. Morrow [1.1.1.9.3.8.1.6.3.2.1.1]
- 12 K.H. Morrow [1.1.1.9.3.8.1.6.3.2.1.2]
- 12 M.J. Morrow [1.1.1.9.3.8.1.6.3.2.1.1]
- 11 Lois E Morrow [1.1.1.9.3.8.1.6.3.2.2]
b. 1 Apr 1920 d. 2 Sep 1933
- 11 Jack Morrow [1.1.1.9.3.8.1.6.3.2.1]
- 10 Undrie Richard Morrow [1.1.1.9.3.8.1.6.3.1]
Clark E Templeton b. 26 Feb 1862 d. 28 Mar 1937
- 10 Commodore Dewey Templeton [1.1.1.9.3.8.1.6.3.3]
b. 31 Jul 1899 d. 11 Mar 1967
- 10 Bessie Mae Templeton [1.1.1.9.3.8.1.6.3.4]
b. 28 Feb 1902 d. 10 Aug 1992
Roy Seldon Atwell b. 23 Apr 1900 d. 6 May 1971
- 11 Archie Harold Atwell [1.1.1.9.3.8.1.6.3.4.1]
b. 29 Apr 1920 d. 3 Aug 1976
- 11 James Howard Atwell [1.1.1.9.3.8.1.6.3.4.2]
b. 27 Jul 1926 d. 4 May 2014
Juanita Ellen Stephens b. 24 Apr 1930 d. 18 Sep 2012
- 11 Geraldine Atwell [1.1.1.9.3.8.1.6.3.4.3]
b. 13 Sep 1929 d. 19 Jun 2005
Charles Leslie Pendleton b. 22 May 1927 d. 1983
- 12 H.M. Pendleton [1.1.1.9.3.8.1.6.3.4.3.1]
- 12 D. Pendleton [1.1.1.9.3.8.1.6.3.4.3.2]
- 12 L. Pendleton [1.1.1.9.3.8.1.6.3.4.3.3]
- 12 Daniel Leslie Pendleton [1.1.1.9.3.8.1.6.3.4.3.4]
b. 4 Sep 1949 d. 24 Oct 2006
- 12 Helen Darlene Pendleton [1.1.1.9.3.8.1.6.3.4.3.5]
b. 9 Dec 1950 d. 17 Dec 2017
- 12 Lois Charlene Pendleton [1.1.1.9.3.8.1.6.3.4.3.6]
b. 30 Dec 1951 d. 12 Nov 2015 [ =>]
- 12 Kenneth Duane Pendleton [1.1.1.9.3.8.1.6.3.4.3.7]
b. 24 Jul 1953 d. 28 Apr 1963
- 12 Sandra Kay Pendleton [1.1.1.9.3.8.1.6.3.4.3.8]
b. 22 Oct 1954 d. 3 Nov 1968
- 12 Joyce Yvonne Pendleton [1.1.1.9.3.8.1.6.3.4.3.9]
b. 22 Dec 1955 d. 7 Dec 1973
- 12 Roger Dale Pendleton [1.1.1.9.3.8.1.6.3.4.3.10]
b. 21 Jul 1971 d. 31 Jul 1971
- 12 H.M. Pendleton [1.1.1.9.3.8.1.6.3.4.3.1]
- 11 Baby Boy Atwell [1.1.1.9.3.8.1.6.3.4.4]
b. 1938 d. 1938
- 11 Baby Boy Atwell [1.1.1.9.3.8.1.6.3.4.5]
b. 1939 d. 1939
- 11 Archie Harold Atwell [1.1.1.9.3.8.1.6.3.4.1]
- 10 Basell E Tempelton [1.1.1.9.3.8.1.6.3.5]
b. 19 Apr 1905 d. 7 Sep 1974
- 10 Marvin O Templeton [1.1.1.9.3.8.1.6.3.6]
b. Abt 1908
- 10 Lawrence Raymond Templeton [1.1.1.9.3.8.1.6.3.7]
b. Abt 1910
- 10 Evelyn Bell Bernard [1.1.1.9.3.8.1.6.3.8]
b. 23 Aug 1912 d. 11 Nov 2001
- 10 Edmond Hoed Templeton [1.1.1.9.3.8.1.6.3.9]
b. 1 Dec 1917 d. Dec 1993
- 10 Ruby Pauline Templeton [1.1.1.9.3.8.1.6.3.10]
b. 30 Jun 1918 d. 11 Sep 1999
- + Carl Franklin Teer b. 22 Nov 1919 d. 28 Dec 1994
- + King
- + Carl Franklin Teer b. 22 Nov 1919 d. 28 Dec 1994
- 10 Commodore Dewey Templeton [1.1.1.9.3.8.1.6.3.3]
- 9 William Alfred Monroe [1.1.1.9.3.8.1.6.4]
b. 30 Nov 1877 d. 26 May 1878
- 9 George Calvin Monroe [1.1.1.9.3.8.1.6.5]
b. 23 Oct 1879 d. 15 Mar 1966
Cora Frances Thomas b. 10 May 1881 d. 18 Jun 1970
- 10 Infant Monroe [1.1.1.9.3.8.1.6.5.1]
b. 24 Dec 1907 d. 24 Dec 1907
- 10 George Calvin Monroe, Jr [1.1.1.9.3.8.1.6.5.2]
b. 9 Oct 1909 d. 29 Apr 1990
W.R. Culp
- 11 L.E. Monroe [1.1.1.9.3.8.1.6.5.2.1]
K.A. Brummett
- 12 S.A. Monroe [1.1.1.9.3.8.1.6.5.2.1.1]
- 12 J.E. Monroe [1.1.1.9.3.8.1.6.5.2.1.2]
- 12 S.A. Monroe [1.1.1.9.3.8.1.6.5.2.1.1]
- 11 G.T. Monroe [1.1.1.9.3.8.1.6.5.2.2]
- 11 L.E. Monroe [1.1.1.9.3.8.1.6.5.2.1]
- 10 John Thomas Monroe [1.1.1.9.3.8.1.6.5.3]
b. 4 Jan 1912 d. 16 Mar 1914
- 10 Edwin Ulys Monroe [1.1.1.9.3.8.1.6.5.4]
b. 25 Feb 1915 d. 20 Jan 1945
Doris Mae Driggers b. 11 Jul 1916 d. 31 Dec 2006
- 11 L.F. Monroe [1.1.1.9.3.8.1.6.5.4.1]
- + Burton
- + Burton
- 11 B.B. Monroe [1.1.1.9.3.8.1.6.5.4.2]
- + Hardy
- + Hardy
- 11 L.F. Monroe [1.1.1.9.3.8.1.6.5.4.1]
- 10 Infant Monroe [1.1.1.9.3.8.1.6.5.1]
- 9 Lillie Maude Monroe [1.1.1.9.3.8.1.6.6]
b. 16 Jul 1882 d. 15 Aug 1974
Thomas David Gregory b. 23 Feb 1878 d. 20 Feb 1963
- 10 Maynard Monroe Gregory [1.1.1.9.3.8.1.6.6.1]
b. 8 Dec 1900 d. 13 Mar 1909
- 10 Maurice T Gregory [1.1.1.9.3.8.1.6.6.2]
b. 29 Jul 1906
- 10 Maynard Monroe Gregory [1.1.1.9.3.8.1.6.6.1]
- 9 Ulysses Sidney Monroe, MD [1.1.1.9.3.8.1.6.7]
b. 14 Nov 1885 d. 15 Apr 1961
Edna Lee Howard b. 6 Sep 1885 d. 22 Sep 1976
- 10 Lance Truman Monroe, MD [1.1.1.9.3.8.1.6.7.1]
b. 6 May 1906 d. 7 Jun 1994
Edythe Mae Smith b. Abt 1914 d. 4 Jul 1972
- 11 M.A. Monroe [1.1.1.9.3.8.1.6.7.1.1]
- 11 N.L. Monroe [1.1.1.9.3.8.1.6.7.1.2]
- 11 L.T. Monroe [1.1.1.9.3.8.1.6.7.1.3]
- 11 K. Monroe [1.1.1.9.3.8.1.6.7.1.4]
- 11 E.A. Monroe [1.1.1.9.3.8.1.6.7.1.5]
- 11 M.A. Monroe [1.1.1.9.3.8.1.6.7.1.1]
- 10 Edna Geneva Monroe [1.1.1.9.3.8.1.6.7.2]
b. 12 Feb 1910 d. 17 Feb 2003
Benjamin Phillip Adams, Jr b. 10 Jan 1911 d. 15 Jun 1995
- 11 Edna Geraldine Adams [1.1.1.9.3.8.1.6.7.2.1]
b. 1 Sep 1940 d. 14 May 2005
- 11 B.P. Adams, III [1.1.1.9.3.8.1.6.7.2.2]
M. Ridenour
- 12 B.P. Adams, IV [1.1.1.9.3.8.1.6.7.2.2.1]
- 12 B.P. Adams, IV [1.1.1.9.3.8.1.6.7.2.2.1]
- 11 Edna Geraldine Adams [1.1.1.9.3.8.1.6.7.2.1]
- 10 Stanley Eugene Monroe, MD [1.1.1.9.3.8.1.6.7.3]
b. 31 Dec 1912 d. 30 Dec 2005
Minnie Eleanor Duncan b. 10 Aug 1919 d. 9 May 2016
- 11 Stanley Eugene Monroe, Jr [1.1.1.9.3.8.1.6.7.3.1]
b. 20 Feb 1944 d. 21 Jun 2011
- + J. Hill
C.L. Hudnall
- 12 J. Monroe [1.1.1.9.3.8.1.6.7.3.1.1]
- 12 J.H. Monroe [1.1.1.9.3.8.1.6.7.3.1.2]
- 12 J. Monroe [1.1.1.9.3.8.1.6.7.3.1.1]
- + J. Hill
- 11 A.D. Monroe [1.1.1.9.3.8.1.6.7.3.2]
- 11 R.M. Monroe [1.1.1.9.3.8.1.6.7.3.3]
- + N. Slaughter
H.J. Portman
- 12 C.A. Monroe [1.1.1.9.3.8.1.6.7.3.3.1]
- 12 C.A. Monroe [1.1.1.9.3.8.1.6.7.3.3.1]
- + N. Slaughter
- 11 K. Monroe [1.1.1.9.3.8.1.6.7.3.4]
J.Y. Buchanan
- 12 E.Y. Buchanan [1.1.1.9.3.8.1.6.7.3.4.1]
- 12 E.Y. Buchanan [1.1.1.9.3.8.1.6.7.3.4.1]
- 11 E. Monroe [1.1.1.9.3.8.1.6.7.3.5]
- + Woodard
T.J. Minor
- 12 Shannon Leigh Minor [1.1.1.9.3.8.1.6.7.3.5.1]
b. 20 Feb 1974 d. 7 Sep 1974
- 12 Shannon Leigh Minor [1.1.1.9.3.8.1.6.7.3.5.1]
- + Woodard
- 11 Stanley Eugene Monroe, Jr [1.1.1.9.3.8.1.6.7.3.1]
- 10 Howard Ulysess Monroe, MD [1.1.1.9.3.8.1.6.7.4]
b. 13 Jan 1917 d. 24 Apr 2002
- + Grace Irene Jenkins b. 3 Jan 1925 d. 27 Apr 1976
- + Grace Irene Jenkins b. 3 Jan 1925 d. 27 Apr 1976
- 10 Geraldine Monroe [1.1.1.9.3.8.1.6.7.5]
b. 4 Jul 1918 d. 29 Aug 2011
Andrew Nunan McCurry b. 4 Apr 1914 d. 16 May 1981
- 11 A.L. McCurry [1.1.1.9.3.8.1.6.7.5.1]
P. Wade
- 12 J. Wade [1.1.1.9.3.8.1.6.7.5.1.1]
- 12 J. Wade [1.1.1.9.3.8.1.6.7.5.1.1]
R.C. Black
- 12 K.A. Black [1.1.1.9.3.8.1.6.7.5.1.2]
- 12 K.A. Black [1.1.1.9.3.8.1.6.7.5.1.2]
- 11 M. McCurry [1.1.1.9.3.8.1.6.7.5.2]
Richard Ronald Reynolds b. 10 Apr 1945 d. 23 Nov 1995
- 12 R. Reynolds [1.1.1.9.3.8.1.6.7.5.2.1]
- 12 C. Reynolds [1.1.1.9.3.8.1.6.7.5.2.2]
- 12 R. Reynolds [1.1.1.9.3.8.1.6.7.5.2.1]
- 11 Mary Monroe McCurry [1.1.1.9.3.8.1.6.7.5.3]
b. 24 Oct 1951 d. 27 Aug 2011
- 11 A.L. McCurry [1.1.1.9.3.8.1.6.7.5.1]
- 10 Lance Truman Monroe, MD [1.1.1.9.3.8.1.6.7.1]
- 9 Emmett Harrison Monroe [1.1.1.9.3.8.1.6.8]
b. 9 Feb 1889 d. 2 Aug 1962
- 9 Nancy Ann Monroe [1.1.1.9.3.8.1.6.9]
b. 20 Mar 1892 d. 22 Apr 1916
Loran Ardee Bane b. 30 Aug 1888 d. 21 Oct 1969
- 10 Loren Edwin Bane [1.1.1.9.3.8.1.6.9.1]
b. 18 Feb 1914 d. 28 Dec 1994
Betty Lee McClammer b. 22 Jul 1922 d. 8 Apr 2001
- 11 S.L. Bane [1.1.1.9.3.8.1.6.9.1.1]
- + F. McLafferty
T.J. Corcoran
- 12 K.C. Corcoran [1.1.1.9.3.8.1.6.9.1.1.1]
- 12 K.C. Corcoran [1.1.1.9.3.8.1.6.9.1.1.1]
- + F. McLafferty
- 11 Edwin Lee Bane [1.1.1.9.3.8.1.6.9.1.2]
b. 24 Oct 1944 d. 2012
- 11 L.T. Bane [1.1.1.9.3.8.1.6.9.1.3]
- 11 L.L. Bane [1.1.1.9.3.8.1.6.9.1.4]
James Emerson Brady b. 22 Mar 1953 d. 27 Nov 2007
- 12 J.L. Brady [1.1.1.9.3.8.1.6.9.1.4.1]
- 12 J.L. Brady [1.1.1.9.3.8.1.6.9.1.4.1]
- 11 S.L. Bane [1.1.1.9.3.8.1.6.9.1.1]
- 10 Loren Edwin Bane [1.1.1.9.3.8.1.6.9.1]
- 9 Alfred Edwin Monroe, MD [1.1.1.9.3.8.1.6.1]
- 8 Tildon Howard Monroe [1.1.1.9.3.8.1.7]
b. Jul 1847 d. 8 Apr 1936
Malderene M Neil b. Apr 1852 d. 12 Apr 1927
- 9 Leona A Monroe [1.1.1.9.3.8.1.7.1]
b. 1868 d. 3 Mar 1923
- 9 Sam Melton Monroe [1.1.1.9.3.8.1.7.2]
b. 26 Dec 1868 d. 29 Mar 1956
Mary Elizabeth Evans, . b. 29 Mar 1865 d. 26 Nov 1940
- 10 Eddie Beecher Monroe [1.1.1.9.3.8.1.7.2.1]
b. 6 May 1888 d. 9 May 1961
- 10 Earon Homer Monroe [1.1.1.9.3.8.1.7.2.2]
b. 5 Nov 1890 d. 26 Nov 1971
Maude Chloe Akins b. 23 Jul 1893 d. 10 Nov 1960
- 11 Mildred Mae Monroe [1.1.1.9.3.8.1.7.2.2.1]
b. 26 Mar 1913 d. 9 Apr 2014
- + Virgle Monroe Barnes b. 28 Sep 1907 d. 7 Apr 1995
- + Virgle Monroe Barnes b. 28 Sep 1907 d. 7 Apr 1995
- 11 Ruby Lee Monroe [1.1.1.9.3.8.1.7.2.2.2]
b. 29 Sep 1914 d. 8 Dec 1990
- 11 James Milton Monroe [1.1.1.9.3.8.1.7.2.2.3]
b. 14 May 1917 d. 20 Sep 1970
Eunice Illene Stewart b. 11 Apr 1921 d. 4 Feb 1998
- 12 J.R. Monroe [1.1.1.9.3.8.1.7.2.2.3.1]
- 12 W.J. Monroe [1.1.1.9.3.8.1.7.2.2.3.2]
- 12 L.J. Monroe [1.1.1.9.3.8.1.7.2.2.3.3]
- 12 J.R. Monroe [1.1.1.9.3.8.1.7.2.2.3.1]
- 11 Earon Ruth Monroe [1.1.1.9.3.8.1.7.2.2.4]
b. 26 Mar 1919 d. 5 Mar 2006
Alton S Williams b. Abt 1916
- 12 A.H. Williams [1.1.1.9.3.8.1.7.2.2.4.1]
- 12 A.W. Williams [1.1.1.9.3.8.1.7.2.2.4.2]
- 12 P.E. Williams [1.1.1.9.3.8.1.7.2.2.4.3]
- 12 A.H. Williams [1.1.1.9.3.8.1.7.2.2.4.1]
- 11 Homer Weldon Monroe [1.1.1.9.3.8.1.7.2.2.5]
b. 25 Jul 1921 d. 3 May 2012
- 11 Charis Ardell Monroe [1.1.1.9.3.8.1.7.2.2.6]
b. 6 Sep 1923 d. 19 Nov 2007
Wanda Lucille Moser b. 4 Nov 1928 d. 6 Jan 2016
- 12 B.A. Monroe [1.1.1.9.3.8.1.7.2.2.6.1]
- 12 S.Y. Monroe [1.1.1.9.3.8.1.7.2.2.6.2]
- 12 Leonard Ardell Monroe [1.1.1.9.3.8.1.7.2.2.6.3]
b. 27 Sep 1958 d. 29 Jan 1960
- 12 B.A. Monroe [1.1.1.9.3.8.1.7.2.2.6.1]
- 11 R L Monroe [1.1.1.9.3.8.1.7.2.2.7]
b. Abt 1924 d. 3 May 2012
- 11 Veoma Maudine Monroe [1.1.1.9.3.8.1.7.2.2.8]
b. 3 Mar 1925 d. 17 Jun 2013
- + Elmer Lloyd Fisher b. 6 Dec 1924 d. 12 Jun 2004
- + Elmer Lloyd Fisher b. 6 Dec 1924 d. 12 Jun 2004
- 11 P.J. Monroe [1.1.1.9.3.8.1.7.2.2.9]
- 11 L.J. Monroe [1.1.1.9.3.8.1.7.2.2.10]
- 11 Patricia Ann Monroe [1.1.1.9.3.8.1.7.2.2.11]
b. 4 Nov 1939 d. 5 May 2021
- 11 Mildred Mae Monroe [1.1.1.9.3.8.1.7.2.2.1]
- 10 Lela Mae Monroe [1.1.1.9.3.8.1.7.2.3]
b. 15 Jun 1900 d. 13 Aug 1963
- 10 John T Monroe [1.1.1.9.3.8.1.7.2.4]
b. 7 Jun 1907 d. 27 Dec 1991
- 10 Eddie Beecher Monroe [1.1.1.9.3.8.1.7.2.1]
- 9 Nancy Monroe [1.1.1.9.3.8.1.7.3]
b. Abt 1871
- 9 McFarland F Monroe [1.1.1.9.3.8.1.7.4]
b. 26 Jul 1873 d. 7 Jul 1945
- 9 James Albert Clark Monroe [1.1.1.9.3.8.1.7.5]
b. 3 Oct 1873 d. 11 Nov 1964
- 9 Albert Monroe [1.1.1.9.3.8.1.7.6]
b. Oct 1876
- 9 David Edgar Monroe [1.1.1.9.3.8.1.7.7]
b. 22 Apr 1878 d. 26 Jun 1959
- 9 Martha Monroe [1.1.1.9.3.8.1.7.8]
b. 26 Apr 1884 d. 7 Aug 1955
- 9 George Emerson Monroe [1.1.1.9.3.8.1.7.9]
b. 16 May 1888 d. 4 Dec 1967
- 9 Owen Oscar Monroe [1.1.1.9.3.8.1.7.10]
b. 1 Aug 1889 d. 2 Jul 1966
- 9 Ruel L Monroe [1.1.1.9.3.8.1.7.11]
b. 27 Jun 1894 d. 25 Jul 1980
- 9 Myrtle Monroe [1.1.1.9.3.8.1.7.12]
b. Jul 1895
- 9 Leona A Monroe [1.1.1.9.3.8.1.7.1]
- 8 Woodson Taylor Monroe [1.1.1.9.3.8.1.8]
b. 13 Jan 1848 d. 30 Apr 1930
- 8 William George Monroe [1.1.1.9.3.8.1.9]
b. 1849 d. 1896
- 8 Lucinda Monroe [1.1.1.9.3.8.1.10]
b. 1853
- 8 Lee Anderson Monroe [1.1.1.9.3.8.1.11]
b. May 1854 d. 27 Jan 1924
- 8 Mark M Monroe [1.1.1.9.3.8.1.1]
- 7 Lucinda Monroe [1.1.1.9.3.8.2]
b. 27 Apr 1816 d. 14 Oct 1871
- 7 Calvin Monroe [1.1.1.9.3.8.3]
b. 22 May 1818 d. 7 Feb 1871
- 7 James L Monroe [1.1.1.9.3.8.4]
b. 30 Mar 1820 d. 23 Sep 1936
Margaret Bryan b. 1824 d. Aft 1870
- 8 Martha J Monroe [1.1.1.9.3.8.4.1]
b. 1843 d. Yes, date unknown
- 8 Hester Ann Monroe [1.1.1.9.3.8.4.2]
b. Abt 1844
- 8 Elvina Monroe [1.1.1.9.3.8.4.3]
b. Abt 1846
- 8 Alexander Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4]
b. 19 Mar 1846 d. 29 Jul 1926
Martha Jane Miller b. 22 Apr 1845 d. 22 Apr 1920
- 9 August Kurvurul Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.1]
b. 21 Dec 1867 d. 21 Apr 1931
Annie Louise McDaniel b. 7 Jul 1872 d. 6 Feb 1968
- 10 Robert Steele Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.1.1]
b. 27 Sep 1893 d. 5 Jun 1969
- + Grace Dea Cramer b. 13 Nov 1898 d. 1985
- + Grace Dea Cramer b. 13 Nov 1898 d. 1985
- 10 Carrie Belle Grace Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.1.2]
b. 8 Oct 1897 d. 3 Feb 1987
August Brown Barnhouse b. 16 Jul 1890 d. 29 Nov 1965
- 11 Madeline Louise Barnhouse [1.1.1.9.3.8.4.4.1.2.1]
b. 16 Nov 1916 d. 31 Mar 1977
- 11 Norma Ruth Barnhouse [1.1.1.9.3.8.4.4.1.2.2]
b. 2 Sep 1920 d. 17 Jun 2011
Charles Arthur Crane b. 8 Nov 1917 d. 15 Nov 1992
- + James William Helms b. 10 Jan 1915 d. 25 Jun 1986
- 11 August Frederick Monroe Barnhouse [1.1.1.9.3.8.4.4.1.2.3]
b. 11 Jun 1922 d. 3 Mar 2009
Alpha Elizabeth Stephens b. 27 May 1922 d. 7 Nov 2006
- 12 D.E. Barnhouse [1.1.1.9.3.8.4.4.1.2.3.1]
[ =>]
- 12 S.M. Barnhouse [1.1.1.9.3.8.4.4.1.2.3.2]
- 12 D.E. Barnhouse [1.1.1.9.3.8.4.4.1.2.3.1]
- 11 Madeline Louise Barnhouse [1.1.1.9.3.8.4.4.1.2.1]
- 10 Esther Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.1.3]
b. Abt 1903 d. Aug 1992
- 10 Arthur Barnes Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.1.4]
b. 13 Aug 1909 d. 17 Dec 1967
Harriet Lucille Fogle b. 11 Apr 1911 d. 30 Jun 1994
- 11 L.R. Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.1.4.1]
- 11 L.R. Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.1.4.1]
- 10 Robert Steele Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.1.1]
- 9 James Lycircus Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.2]
b. 22 May 1870 d. 2 Apr 1958
Eva Annetta Rice b. 27 Feb 1871 d. 1 Mar 1958
- 10 Cecil Augustus Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.2.1]
b. 21 Mar 1893 d. 22 Mar 1977
- + Elizabeth Rebecca Branson b. 27 Feb 1896 d. 19 Oct 1970
Rosa C Maasen b. 16 Mar 1895 d. 1 May 1966
- 11 Leona E Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.2.1.1]
b. 3 May 1915 d. 14 Oct 1993
- + E. Ott
John Edward Lynch b. 4 Feb 1918 d. 8 Sep 2001
- 12 John Wayne Lynch [1.1.1.9.3.8.4.4.2.1.1.1]
b. 30 Jul 1945 d. 2 Mar 2012 [ =>]
- 12 D.L. Lynch [1.1.1.9.3.8.4.4.2.1.1.2]
- 12 John Wayne Lynch [1.1.1.9.3.8.4.4.2.1.1.1]
- + E. Ott
- 11 Woodrow Fredrick Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.2.1.2]
b. 7 Nov 1916 d. 9 Oct 2004
Lioba Clara Kemper b. 29 Jun 1922 d. 30 May 1967
- 12 D.J. Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.2.1.2.1]
- 12 M.G. Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.2.1.2.2]
- 12 P.D. Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.2.1.2.3]
- 12 D.J. Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.2.1.2.1]
- + Lucinda A Nolting b. 10 May 1918 d. 12 Jan 2006
- 11 Leona E Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.2.1.1]
- + Elizabeth Rebecca Branson b. 27 Feb 1896 d. 19 Oct 1970
- 10 Cale Franklin Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.2.2]
b. 19 Sep 1894 d. 5 May 1971
- + Catherine Christina Richard b. 17 Feb 1895 d. 15 Nov 1990
- + Catherine Christina Richard b. 17 Feb 1895 d. 15 Nov 1990
- 10 Mary Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.2.3]
b. 13 Dec 1896 d. 13 Dec 1896
- 10 Clyde Joseph Monroe, Sr [1.1.1.9.3.8.4.4.2.4]
b. 19 Nov 1897 d. 26 Mar 1976
Estelle Elizabeth Barth b. 20 Aug 1912 d. 29 Jul 1957
- 11 Clyde Joseph Monroe, Jr [1.1.1.9.3.8.4.4.2.4.1]
b. 22 Jan 1937 d. 10 Oct 2005
M.Y. Von Dullen
- 12 Sherryl Lynn Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.2.4.1.1]
b. 22 Aug 1960 d. 27 Sep 2020 [ =>]
- 12 Christine Leslie Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.2.4.1.2]
b. 15 Aug 1962 d. 16 Jul 2019 [ =>]
- 12 K.M. Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.2.4.1.3]
- 12 Sherryl Lynn Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.2.4.1.1]
- 11 Clyde Joseph Monroe, Jr [1.1.1.9.3.8.4.4.2.4.1]
- 10 Laverta Floy Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.2.5]
b. 25 Jul 1900 d. 21 Nov 1987
Anthony Villegas b. 17 Jan 1897 d. 21 Apr 1952
- 11 D. Villegas [1.1.1.9.3.8.4.4.2.5.1]
- 11 C. Villegas [1.1.1.9.3.8.4.4.2.5.2]
- 11 D. Villegas [1.1.1.9.3.8.4.4.2.5.1]
- 10 James Lafayette Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.2.6]
b. 8 Sep 1904 d. 22 Feb 1986
- 10 James Lon Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.2.7]
b. 1905 d. Bef 5 May 1971
- 10 Myrtle Faye Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.2.8]
b. 28 Feb 1905 d. 21 Feb 1950
Walter E Scott b. 3 Dec 1897 d. 22 Oct 1979
- 11 Olive LaRue Scott [1.1.1.9.3.8.4.4.2.8.1]
b. 13 Aug 1923 d. 20 May 1999
Dallas M McKee b. 23 Apr 1922 d. 6 Oct 2005
- 12 C.D. McKee [1.1.1.9.3.8.4.4.2.8.1.1]
- 12 Teri BeLinda McKee [1.1.1.9.3.8.4.4.2.8.1.2]
b. 22 Jul 1946 d. 25 Jan 1965
- 12 Toni LaLinda McKee [1.1.1.9.3.8.4.4.2.8.1.3]
b. 22 Jul 1946 d. 14 Jun 1991
- 12 C.D. McKee [1.1.1.9.3.8.4.4.2.8.1.1]
- 11 Jacquelyn Annette Scott [1.1.1.9.3.8.4.4.2.8.2]
b. 4 Jun 1925 d. 18 May 2008
Holland Edward Reece b. 9 Apr 1920 d. 3 Jun 1990
- 12 Hollis Ann Reece [1.1.1.9.3.8.4.4.2.8.2.1]
b. 3 Jul 1941 d. 12 Apr 2009
- 12 Scott Ashley Reece [1.1.1.9.3.8.4.4.2.8.2.2]
b. 20 Sep 1942 d. 28 Jul 2014
- 12 Nancy Adeline Reece [1.1.1.9.3.8.4.4.2.8.2.3]
b. 9 Jul 1943 d. 22 Feb 2021
- 12 Steven Edward Reece [1.1.1.9.3.8.4.4.2.8.2.4]
b. 31 Jul 1945 d. 24 Apr 2016
- 12 Stacey Dana Reece [1.1.1.9.3.8.4.4.2.8.2.5]
b. 7 May 1949 d. 28 Feb 1968
- 12 Kelly Faith Reece [1.1.1.9.3.8.4.4.2.8.2.6]
b. 31 Oct 1956 d. 6 Apr 2016
- 12 Hollis Ann Reece [1.1.1.9.3.8.4.4.2.8.2.1]
- 11 Leatha Joy Scott [1.1.1.9.3.8.4.4.2.8.3]
b. 16 Mar 1927 d. 29 Jul 1994
- + Leo J Zipp b. 9 Dec 1921 d. 27 Aug 2005
- + Leo J Zipp b. 9 Dec 1921 d. 27 Aug 2005
- 11 Waldean Maxie Scott [1.1.1.9.3.8.4.4.2.8.4]
b. 10 Aug 1928 d. 3 Mar 2005
Paul Glenwood Hurt b. 11 Aug 1922 d. 25 Jan 2003
- 12 Paula F Hurt [1.1.1.9.3.8.4.4.2.8.4.1]
b. 6 May 1948 d. 7 Feb 2009
- 12 Paula F Hurt [1.1.1.9.3.8.4.4.2.8.4.1]
- 11 James Monroe Scott [1.1.1.9.3.8.4.4.2.8.5]
b. 20 Jun 1931 d. 3 Jan 2002
- + Norma Louise Cowan b. 1925 d. 4 Jul 2012
- + Norma Louise Cowan b. 1925 d. 4 Jul 2012
- 11 Olive LaRue Scott [1.1.1.9.3.8.4.4.2.8.1]
- 10 Myrtle Faye Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.2.9]
b. 28 Feb 1905 d. 21 Feb 1950
Walter E Scott b. 3 Dec 1897 d. 22 Oct 1979
- 11 Olive Larue Scott [1.1.1.9.3.8.4.4.2.9.1]
b. 13 Aug 1923 d. 20 May 1999
- 11 Jacquelyn Annette Scott [1.1.1.9.3.8.4.4.2.9.2]
b. 4 Jun 1925 d. 18 May 2008
- 11 Leatha Joy Scott [1.1.1.9.3.8.4.4.2.9.3]
b. 16 Mar 1927 d. 29 Jul 1994
- 11 Waldean Maxie Scott [1.1.1.9.3.8.4.4.2.9.4]
b. Abt 1929 d. 3 Mar 2005
- 11 James Monroe Scott [1.1.1.9.3.8.4.4.2.9.5]
b. 20 Jun 1931 d. 3 Jan 2002
- 11 Olive Larue Scott [1.1.1.9.3.8.4.4.2.9.1]
- 10 Loren G (Lon) Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.2.10]
b. 9 Jun 1906 d. 5 Dec 1966
- + Eula Carter Rainwater b. 2 May 1905 d. 21 Oct 1947
Mary Renee Ryan Montgomery b. 15 Sep 1927 d. 18 Jul 1983
- 11 L.L. Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.2.10.1]
- 11 L.L. Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.2.10.1]
- + Eula Carter Rainwater b. 2 May 1905 d. 21 Oct 1947
- 10 Lola Mae Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.2.11]
b. 15 Sep 1908 d. 15 Jun 2005
- 10 Allen Paul Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.2.12]
b. 18 Sep 1911 d. 14 Feb 1955
Edith M Price b. Abt 1911
- 11 L.A. Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.2.12.1]
- 11 L.A. Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.2.12.1]
- 10 Adline Fern Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.2.13]
b. 8 Dec 1920 d. 9 May 1997
- 10 Cecil Augustus Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.2.1]
- 9 Adam Aquilla Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.3]
b. 28 May 1872 d. 14 Jul 1949
Florence Lelien Patterson b. 29 Mar 1879 d. 18 Feb 1956
- 10 Frank J Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.3.1]
b. 26 Sep 1898 d. 2 Nov 1929
- 10 Mary Williams Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.3.2]
b. 25 Nov 1900 d. 26 Mar 1972
Edward Clinton Branson b. 20 Feb 1894 d. 22 Jul 1966
- 11 Grace Irene Branson [1.1.1.9.3.8.4.4.3.2.1]
b. 9 May 1918 d. 21 Feb 1988
Wade Oliver Thompson b. 13 Aug 1912 d. 9 Mar 1969
- 12 M. Thompson [1.1.1.9.3.8.4.4.3.2.1.1]
- 12 Melvyn O Thompson [1.1.1.9.3.8.4.4.3.2.1.2]
b. Abt 1939 d. 1940
- 12 M. Thompson [1.1.1.9.3.8.4.4.3.2.1.3]
- 12 M.O. Thompson [1.1.1.9.3.8.4.4.3.2.1.4]
- 12 M. Thompson [1.1.1.9.3.8.4.4.3.2.1.1]
- + Lee Roy Edgar Malan b. 5 Dec 1892 d. 9 Mar 1986
- 11 Velora Pearl Branson [1.1.1.9.3.8.4.4.3.2.2]
b. 7 Dec 1920 d. 14 Jan 1990
- 11 Erleen Juanita Branson [1.1.1.9.3.8.4.4.3.2.3]
b. 3 May 1923 d. 16 Jul 2004
Alfred August Schultz b. 30 Jun 1919 d. 19 Oct 1986
- 12 Alfred Eugene Schultz [1.1.1.9.3.8.4.4.3.2.3.1]
b. 8 Jul 1943 d. 25 Oct 1993
- 12 B.E. Schultz [1.1.1.9.3.8.4.4.3.2.3.2]
- 12 Alfred Eugene Schultz [1.1.1.9.3.8.4.4.3.2.3.1]
- 11 Omar Dallas Branson [1.1.1.9.3.8.4.4.3.2.4]
b. 26 Dec 1925 d. 15 Nov 2010
Virgil Willie Micke b. 17 Oct 1923 d. 19 Feb 1963
- 12 B.J. Micke [1.1.1.9.3.8.4.4.3.2.4.1]
- 12 B.J. Micke [1.1.1.9.3.8.4.4.3.2.4.1]
- + Franklin Delano Lansford b. 14 Nov 1936 d. 8 Oct 2009
- 11 Nadeen Branson [1.1.1.9.3.8.4.4.3.2.5]
b. 10 Mar 1929 d. 17 Dec 2008
- 11 Quilas Thomas Clinton Branson [1.1.1.9.3.8.4.4.3.2.6]
b. 27 Aug 1931 d. 23 Dec 2008
- 11 Mary Ellen Branson [1.1.1.9.3.8.4.4.3.2.7]
b. 27 Aug 1934 d. 16 Oct 1971
- 11 Janett Jerley Branson [1.1.1.9.3.8.4.4.3.2.8]
b. 13 Aug 1937 d. 28 May 2011
- + Ronald Charles Robertson b. 11 Apr 1934 d. 16 Dec 2009
- + Ronald Charles Robertson b. 11 Apr 1934 d. 16 Dec 2009
- 11 J.A. Branson [1.1.1.9.3.8.4.4.3.2.9]
- 11 Grace Irene Branson [1.1.1.9.3.8.4.4.3.2.1]
- 10 Myrtle Melissa Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.3.3]
b. 17 Feb 1904 d. 14 Mar 1968
Lee Roy Edgar Malan b. 5 Dec 1892 d. 9 Mar 1986
- 11 Bernis Adrian Malan [1.1.1.9.3.8.4.4.3.3.1]
b. 12 Mar 1922 d. 1 May 2003
- + Elsie Amanda Lange b. 16 Jan 1911 d. 31 May 2002
- + Elsie Amanda Lange b. 16 Jan 1911 d. 31 May 2002
- 11 Norma Lee Malan [1.1.1.9.3.8.4.4.3.3.2]
b. 26 Nov 1924 d. 27 Dec 2000
Chester R Helmig b. 11 Aug 1919 d. 22 Feb 1993
- 12 J.W. Helmig [1.1.1.9.3.8.4.4.3.3.2.1]
- 12 J.D. Helmig [1.1.1.9.3.8.4.4.3.3.2.2]
- 12 Jimmy Ray Helmig [1.1.1.9.3.8.4.4.3.3.2.3]
b. 7 Oct 1948 d. 16 Apr 1999 [ =>]
- 12 J.W. Helmig [1.1.1.9.3.8.4.4.3.3.2.1]
- 11 Ruth Evelyn Malan [1.1.1.9.3.8.4.4.3.3.3]
b. 1 Sep 1927 d. 1 Mar 2013
Cullen Joseph Clingerman b. 15 Aug 1927 d. 5 Jan 1999
- 12 M. Clingerman [1.1.1.9.3.8.4.4.3.3.3.1]
- 12 C. Clingerman [1.1.1.9.3.8.4.4.3.3.3.2]
- 12 P. Clingerman [1.1.1.9.3.8.4.4.3.3.3.3]
- 12 M. Clingerman [1.1.1.9.3.8.4.4.3.3.3.1]
- 11 Robert Jennings Malan [1.1.1.9.3.8.4.4.3.3.4]
b. 2 May 1930 d. 31 Jan 2017
P.J. Whitehead
- 12 M. Malan [1.1.1.9.3.8.4.4.3.3.4.1]
- 12 William Lee Malan [1.1.1.9.3.8.4.4.3.3.4.2]
b. 19 Sep 1958 d. 26 Mar 2021 [ =>]
- 12 M. Malan [1.1.1.9.3.8.4.4.3.3.4.1]
- 11 R.M. Malan [1.1.1.9.3.8.4.4.3.3.5]
- 11 P.M. Malon [1.1.1.9.3.8.4.4.3.3.6]
- 11 Bernis Adrian Malan [1.1.1.9.3.8.4.4.3.3.1]
- 10 Martha B (Mattie) Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.3.4]
b. 31 Oct 1908 d. 22 Oct 2000
Albert Anton (Bud) Baclesse, Sr b. 5 Jul 1902 d. 26 Apr 1988
- 11 A.M. Baclesse, Jr [1.1.1.9.3.8.4.4.3.4.1]
Melba Laverne Shockley b. 28 Oct 1928 d. 25 Jul 2019
- 12 T.O. Baclesse [1.1.1.9.3.8.4.4.3.4.1.1]
[ =>]
- 12 T.O. Baclesse [1.1.1.9.3.8.4.4.3.4.1.1]
- + B.L. Gibson
- 11 Janice Melba Baclesse [1.1.1.9.3.8.4.4.3.4.2]
b. 6 Feb 1931 d. 2 Apr 2018
Perry Edward (Smitty) Smith b. 10 Sep 1928 d. 5 Oct 2017
- 12 A. Smith [1.1.1.9.3.8.4.4.3.4.2.1]
[ =>]
- 12 Vicky Lynn Smith [1.1.1.9.3.8.4.4.3.4.2.2]
b. 28 Mar 1950 d. 5 Jul 2021 [ =>]
- 12 B.A. Smith [1.1.1.9.3.8.4.4.3.4.2.3]
[ =>]
- 12 Kent (Smitty) Smith [1.1.1.9.3.8.4.4.3.4.2.4]
b. 3 Jun 1961 d. 22 Nov 2020
- 12 B. Smith [1.1.1.9.3.8.4.4.3.4.2.5]
- 12 G. Smith [1.1.1.9.3.8.4.4.3.4.2.6]
- 12 A. Smith [1.1.1.9.3.8.4.4.3.4.2.1]
- 11 Joy Lee Baclesse [1.1.1.9.3.8.4.4.3.4.3]
b. 24 Feb 1933 d. 3 Feb 2020
G.A. Niekamp
- 12 Richard Lee Baclesse [1.1.1.9.3.8.4.4.3.4.3.1]
b. 7 Sep 1958 d. 31 Jul 2013
- 12 Richard Lee Baclesse [1.1.1.9.3.8.4.4.3.4.3.1]
- 11 A.M. Baclesse, Jr [1.1.1.9.3.8.4.4.3.4.1]
- 10 Woodrow M Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.3.5]
b. 30 Nov 1912 d. 18 Feb 1975
- + Beula M Thomas b. Abt 1917
- + Beula M Thomas b. Abt 1917
- 10 Earl Aquilla Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.3.6]
b. 23 Sep 1915 d. 28 Aug 1987
Irene Virginia Branson b. 4 Mar 1921 d. 7 Aug 1990
- 11 Ronald Lee Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.3.6.1]
b. 14 Oct 1941 d. 2 May 1976
- 11 Shirley Mae Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.3.6.2]
b. 22 Apr 1943 d. 18 Jul 2011
- 11 S.K. Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.3.6.3]
Dennis Wayne (Frog) Boss b. 17 Nov 1946 d. 25 Jun 2024
- 11 Ronald Lee Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.3.6.1]
- + Mildred Huron Parker b. 19 Sep 1917 d. 5 Mar 2010
- 10 Howard Trenton (Tom) Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.3.7]
b. 29 Jan 1921 d. 11 Jun 1982
Mary J _____ b. Abt 1910
- 11 R.J. Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.3.7.1]
- 11 R.J. Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.3.7.1]
Neva Doreen Clark b. 12 Dec 1924 d. 23 Mar 2001
- 11 D.R. Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.3.7.2]
- 11 Virginia Mary Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.3.7.3]
b. 28 Feb 1951 d. 10 Jan 1984
- 11 Daniel Dwain Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.3.7.4]
b. 7 Jul 1953 d. 26 Jan 2008
- 11 D.R. Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.3.7.2]
- 10 Frank J Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.3.1]
- 9 Horace Maynard (Maine) Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.4]
b. 30 Jan 1875 d. 29 Apr 1956
Lucy Evelina Kerley b. 9 Sep 1883 d. 8 Aug 1965
- 10 William Benton Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.4.1]
b. 1 Feb 1904 d. 2 Jun 1982
Josephine Billie Branson b. 22 Mar 1918 d. 21 Jan 1994
- 11 Larry L Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.4.1.1]
b. 16 Mar 1939 d. 4 Jul 2021
- 11 L.L. Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.4.1.2]
- 11 Larry L Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.4.1.1]
- 10 Leroy A Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.4.2]
b. 10 Feb 1906 d. 19 Dec 1977
- 10 Raymond Oscar Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.4.3]
b. 19 Jun 1908 d. 13 Nov 1993
Ruth Hassler b. 1917 d. 27 Nov 1992
- 11 Y.A. Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.4.3.1]
- + Leigers
- + Leigers
- 11 Y.L. Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.4.3.2]
- 11 Robert Eugene Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.4.3.3]
b. 29 Aug 1936 d. 16 Feb 2000
- 11 Rosella T Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.4.3.4]
b. 21 Aug 1937 d. 19 Jan 1967
- 11 Y.A. Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.4.3.1]
- 10 Catherine Virginia Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.4.4]
b. 28 Jan 1911 d. 11 May 1997
Albert Baumgartner b. 1 Dec 1906 d. 17 Sep 1971
- 11 R. Baumgartner [1.1.1.9.3.8.4.4.4.4.1]
- 11 R. Baumgartner [1.1.1.9.3.8.4.4.4.4.1]
- + James Monroe Fink d. 1974
- 10 William Benton Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.4.1]
- 9 Addison Jones (Doc) Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.5]
b. 10 Oct 1877 d. 29 Jan 1928
Martha Ann (Mug) Smith b. 4 Apr 1883 d. 13 May 1965
- 10 Flossie Moneka Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.5.1]
b. 18 Mar 1900 d. 29 Apr 1980
William Clyde Curtit b. 21 Jan 1893 d. 14 Jan 1962
- 11 Maurine Ruth Curtit [1.1.1.9.3.8.4.4.5.1.1]
b. 10 Mar 1920 d. 15 Jun 1920
- 11 Connie Monroe Curtit [1.1.1.9.3.8.4.4.5.1.2]
b. 1 May 1921 d. 22 Nov 1965
Clara A Nilges b. 2 Sep 1923 d. 11 Feb 2002
- 12 Judith Ann Curtit [1.1.1.9.3.8.4.4.5.1.2.1]
b. 30 Sep 1941 d. 10 Mar 2006 [ =>]
- 12 J.W. Curtit [1.1.1.9.3.8.4.4.5.1.2.2]
- 12 Jerry Wayne Curtit [1.1.1.9.3.8.4.4.5.1.2.3]
b. 16 Feb 1947 d. 7 Jul 2015
- 12 S. Curtit [1.1.1.9.3.8.4.4.5.1.2.4]
- 12 Judith Ann Curtit [1.1.1.9.3.8.4.4.5.1.2.1]
- 11 Donald Robert Curtit, Sr [1.1.1.9.3.8.4.4.5.1.3]
b. 28 Aug 1923 d. 29 Aug 1973
Zelma Gunn b. 4 Dec 1923 d. 11 Mar 1994
- 12 D.R. Curtit, Jr [1.1.1.9.3.8.4.4.5.1.3.1]
- 12 Steven Arthur Curtit [1.1.1.9.3.8.4.4.5.1.3.2]
b. 11 Jan 1954 d. 9 Aug 1980
- 12 D.R. Curtit, Jr [1.1.1.9.3.8.4.4.5.1.3.1]
- 11 Billy Gene Curtit [1.1.1.9.3.8.4.4.5.1.4]
b. 7 Aug 1927 d. 22 Jul 1997
Margarette Louise (Dixie) Fowler b. 25 Jul 1928 d. 5 Apr 2012
- 12 M.K. Curtit [1.1.1.9.3.8.4.4.5.1.4.1]
- 12 J. Curtit [1.1.1.9.3.8.4.4.5.1.4.2]
- 12 J.L. Curtit [1.1.1.9.3.8.4.4.5.1.4.3]
[ =>]
- 12 Samuel Clyde Curtit [1.1.1.9.3.8.4.4.5.1.4.4]
b. 7 Aug 1957 d. 7 Aug 1957
- 12 B.G. Curtit [1.1.1.9.3.8.4.4.5.1.4.5]
- 12 M.K. Curtit [1.1.1.9.3.8.4.4.5.1.4.1]
- 11 Maurine Ruth Curtit [1.1.1.9.3.8.4.4.5.1.1]
- 10 Nannie Vern Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.5.2]
b. 14 Feb 1902 d. 14 Sep 1970
George Thomas Kemple b. 4 Jul 1899 d. 5 Feb 1975
- 11 Floyd Glenn Kemple [1.1.1.9.3.8.4.4.5.2.1]
b. 1 Dec 1921 d. 20 Jan 1984
Mildred Ann Kemple b. 23 Oct 1927 d. 19 Apr 2012
- 12 A.J. Kemple [1.1.1.9.3.8.4.4.5.2.1.1]
[ =>]
- 12 Randall Lee Kemple [1.1.1.9.3.8.4.4.5.2.1.2]
b. 8 Dec 1952 d. 25 Oct 2019 [ =>]
- 12 R.W. Kemple [1.1.1.9.3.8.4.4.5.2.1.3]
[ =>]
- 12 G.A. Kemple [1.1.1.9.3.8.4.4.5.2.1.4]
- 12 A.J. Kemple [1.1.1.9.3.8.4.4.5.2.1.1]
- 11 Mary Louise Kemple [1.1.1.9.3.8.4.4.5.2.2]
b. 29 Mar 1924 d. 2 Jan 2006
Earl Joseph (E J) Banks, Jr b. 9 Aug 1923 d. 26 Jun 2011
- 12 L.G. Banks [1.1.1.9.3.8.4.4.5.2.2.1]
[ =>]
- 12 Kenneth LaVern Banks [1.1.1.9.3.8.4.4.5.2.2.2]
b. 5 Oct 1949 d. 7 Jun 2012 [ =>]
- 12 Lynda Ruth Banks [1.1.1.9.3.8.4.4.5.2.2.3]
b. 17 Jul 1951 d. 1 Jan 2017 [ =>]
- 12 R.L. Banks [1.1.1.9.3.8.4.4.5.2.2.4]
[ =>]
- 12 L.G. Banks [1.1.1.9.3.8.4.4.5.2.2.1]
- 11 Vivian Rea Kemple [1.1.1.9.3.8.4.4.5.2.3]
b. 26 Feb 1926 d. 25 Oct 2023
Milford Paul Spurgeon b. 4 Mar 1926 d. 20 May 2016
- 12 R.E. Spurgeon [1.1.1.9.3.8.4.4.5.2.3.1]
[ =>]
- 12 K.M. Spurgeon [1.1.1.9.3.8.4.4.5.2.3.2]
[ =>]
- 12 E.P. Spurgeon [1.1.1.9.3.8.4.4.5.2.3.3]
[ =>]
- 12 S.W. Spurgeon [1.1.1.9.3.8.4.4.5.2.3.4]
[ =>]
- 12 B.K. Spurgeon [1.1.1.9.3.8.4.4.5.2.3.5]
[ =>]
- 12 R.E. Spurgeon [1.1.1.9.3.8.4.4.5.2.3.1]
- 11 Marjorie Ruth Kemple [1.1.1.9.3.8.4.4.5.2.4]
b. 5 Nov 1930 d. 9 Apr 2014
Warren Alden Ridenhour b. 3 Aug 1921 d. 12 Dec 2005
- 12 Thomas Benton Ridenhour [1.1.1.9.3.8.4.4.5.2.4.1]
b. 27 May 1949 d. 16 Jan 1971 [ =>]
- 12 S.G. Ridenhour [1.1.1.9.3.8.4.4.5.2.4.2]
[ =>]
- 12 T.R. Ridenhour [1.1.1.9.3.8.4.4.5.2.4.3]
[ =>]
- 12 Thomas Benton Ridenhour [1.1.1.9.3.8.4.4.5.2.4.1]
- 11 N.L. Kemple [1.1.1.9.3.8.4.4.5.2.5]
- 11 Virginia Kay Kemple [1.1.1.9.3.8.4.4.5.2.6]
b. 9 Dec 1943 d. 28 Jul 2021
David Leslie Gilpin b. 29 Mar 1939 d. 23 May 2006
- 12 D.L. Gilpin [1.1.1.9.3.8.4.4.5.2.6.1]
[ =>]
- 12 J.D. Gilpin [1.1.1.9.3.8.4.4.5.2.6.2]
- 12 S.K. Gilpin [1.1.1.9.3.8.4.4.5.2.6.3]
[ =>]
- 12 D.L. Gilpin [1.1.1.9.3.8.4.4.5.2.6.1]
- 11 Carol Ann Kemple [1.1.1.9.3.8.4.4.5.2.7]
b. 10 Oct 1946 d. 1 Mar 2016
- + Clarence Dean Bowers b. 15 Nov 1945 d. 4 Jul 1991
Robert Lee Heemeier b. 25 Jul 1946 d. 6 Oct 2000
- 12 D.A. Heemeier [1.1.1.9.3.8.4.4.5.2.7.1]
- 12 D.L. Heemeier [1.1.1.9.3.8.4.4.5.2.7.2]
- 12 D.A. Heemeier [1.1.1.9.3.8.4.4.5.2.7.1]
L.J. Moore
- 12 Melissa Eileen Moore [1.1.1.9.3.8.4.4.5.2.7.3]
b. 21 Nov 1971 d. 12 Feb 2019 [ =>]
- 12 Melissa Eileen Moore [1.1.1.9.3.8.4.4.5.2.7.3]
- + D.T. Green
- + Richard Glen Meeks, Jr b. 7 Nov 1948 d. 8 Feb 2009
- + Clarence Dean Bowers b. 15 Nov 1945 d. 4 Jul 1991
- 11 Floyd Glenn Kemple [1.1.1.9.3.8.4.4.5.2.1]
- 10 Robert Steele Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.5.3]
b. 18 Jun 1905 d. 24 Jan 1957
Martha Opal (Mattie) Bacon b. 16 Nov 1906 d. 10 Mar 1998
- 11 Robert Bacon Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.5.3.1]
b. 25 Mar 1927 d. 15 Jan 1937
- 11 Robert Bacon Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.5.3.1]
Viola Edith Leach b. 28 Jun 1912 d. 20 Jun 2000
- 11 Michael Edward Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.5.3.2]
b. 22 Jan 1944 d. 26 Jul 1944
- 11 Marsha Gay Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.5.3.3]
b. 14 Jul 1946 d. 24 Sep 1968
- + R.L. Hill
- + Charles Olivar Angell b. 30 Nov 1944 d. 9 Feb 2006
- + R.L. Hill
- 11 Michael Edward Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.5.3.2]
- 10 Maude Grace Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.5.4]
b. 9 Jan 1908 d. Feb 1982
Leonard Lonzo Eastham b. 21 Jan 1901 d. 6 Dec 1986
- 11 Lonnie Lee Eastham [1.1.1.9.3.8.4.4.5.4.1]
b. 27 Aug 1928 d. 14 Sep 2016
M.D. Howell
- 12 M.L. Eastham [1.1.1.9.3.8.4.4.5.4.1.1]
- 12 M.L. Eastham [1.1.1.9.3.8.4.4.5.4.1.1]
- 11 Patrica Ann Eastham [1.1.1.9.3.8.4.4.5.4.2]
b. 26 Oct 1934 d. 7 Mar 2017
J. Elder
- 12 L.E. Elder [1.1.1.9.3.8.4.4.5.4.2.1]
- 12 L.E. Elder [1.1.1.9.3.8.4.4.5.4.2.1]
W.C. Ponder
- 12 M.C. Ponder [1.1.1.9.3.8.4.4.5.4.2.2]
- 12 S.L. Ponder [1.1.1.9.3.8.4.4.5.4.2.3]
- 12 E.L. Ponder [1.1.1.9.3.8.4.4.5.4.2.4]
[ =>]
- 12 M.C. Ponder [1.1.1.9.3.8.4.4.5.4.2.2]
Leonard Lee Neal b. 14 Dec 1931 d. 26 Apr 1995
- 12 K.G. Neal [1.1.1.9.3.8.4.4.5.4.2.5]
- 12 K.G. Neal [1.1.1.9.3.8.4.4.5.4.2.5]
- 11 R. Eastham [1.1.1.9.3.8.4.4.5.4.3]
U. Henn
- 12 J. Eastham [1.1.1.9.3.8.4.4.5.4.3.1]
- 12 G.L. Eastham [1.1.1.9.3.8.4.4.5.4.3.2]
- 12 R.H. Eastham [1.1.1.9.3.8.4.4.5.4.3.3]
- 12 J. Eastham [1.1.1.9.3.8.4.4.5.4.3.1]
- 11 Lonnie Lee Eastham [1.1.1.9.3.8.4.4.5.4.1]
- 10 Ruth Nellie Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.5.5]
b. 17 Jul 1910 d. 2 Sep 1996
- + William John Lammert b. 1 Sep 1904 d. 29 Jun 1974
- + William John Lammert b. 1 Sep 1904 d. 29 Jun 1974
- 10 Ester Marie Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.5.6]
b. 21 Sep 1914 d. 1 Mar 1987
Hugo Peter Kemmer b. 18 Dec 1911 d. 19 Apr 2001
- 11 J.H. Kemmer [1.1.1.9.3.8.4.4.5.6.1]
J. Wade
- 12 S.J. Kemmer [1.1.1.9.3.8.4.4.5.6.1.1]
- 12 K.K. Kemmer [1.1.1.9.3.8.4.4.5.6.1.2]
- 12 S.J. Kemmer [1.1.1.9.3.8.4.4.5.6.1.1]
- + V.J. Elliott
- 11 Sandra Jean Kemmer [1.1.1.9.3.8.4.4.5.6.2]
b. 26 May 1939 d. 25 Apr 2021
John William Herndon b. 18 Jan 1938 d. 20 May 2016
- 12 K.J. Herndon [1.1.1.9.3.8.4.4.5.6.2.1]
- 12 C.A. Herndon [1.1.1.9.3.8.4.4.5.6.2.2]
- 12 S.L. Herndon [1.1.1.9.3.8.4.4.5.6.2.3]
- 12 K.J. Herndon [1.1.1.9.3.8.4.4.5.6.2.1]
- 11 Jane Rea Kemmer [1.1.1.9.3.8.4.4.5.6.3]
b. 11 Jan 1943 d. 8 Aug 2016
Ronald E Scheel b. 23 Jan 1940 d. 17 Aug 2022
- 12 L.A. Scheel [1.1.1.9.3.8.4.4.5.6.3.1]
[ =>]
- 12 J.S. Scheel [1.1.1.9.3.8.4.4.5.6.3.2]
[ =>]
- 12 L.A. Scheel [1.1.1.9.3.8.4.4.5.6.3.1]
- + Craig Lee Davis b. Abt 1938 d. 30 Apr 2013
- 11 J.A. Kemmer [1.1.1.9.3.8.4.4.5.6.4]
- + Leo Herman (Stu) Hueste, Jr b. 2 Jun 1943 d. 28 Dec 2006
- + Leo Herman (Stu) Hueste, Jr b. 2 Jun 1943 d. 28 Dec 2006
- 11 J.H. Kemmer [1.1.1.9.3.8.4.4.5.6.1]
- 10 Harry Edward Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.5.7]
b. 4 Nov 1921 d. 29 Aug 2004
Louvenia Mae (Vengie) McKenzie b. 30 Jul 1923 d. 30 Apr 2018
- 11 J.R. Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.5.7.1]
- + S. _____
- + S. _____
- 11 James Von Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.5.7.2]
b. 13 May 1961 d. 29 Sep 2022
- 11 J.R. Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.5.7.1]
- 10 Flossie Moneka Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.5.1]
- 9 Louis Edward Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.6]
b. 2 Jun 1880 d. 31 Jan 1965
- 9 Marcus J Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.7]
b. 30 Jul 1884 d. 13 Oct 1970
Sophia Ellen Branson b. 24 Mar 1889 d. 19 May 1990
- 10 Cora Ellen Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.7.1]
b. 16 Dec 1909 d. 7 Sep 1911
- 10 William Reed Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.7.2]
b. 14 Sep 1911 d. 4 Nov 1998
Mildred Lucille Evans b. 12 Jun 1917 d. 12 Mar 1998
- 11 J. Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.7.2.1]
- 11 Lillian Ruth Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.7.2.2]
b. 11 Feb 1935 d. 30 Jan 2017
- + John Francis Nilges b. 14 Nov 1934 d. 16 Aug 1963
- + K.J. Gove
- + John Francis Nilges b. 14 Nov 1934 d. 16 Aug 1963
- 11 E.R. Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.7.2.3]
- + Wanda Lee Swoboda b. 4 Sep 1939 d. 6 Nov 2019
- + Wanda Lee Swoboda b. 4 Sep 1939 d. 6 Nov 2019
- 11 Charles Paul Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.7.2.4]
b. 15 Feb 1945 d. 5 Aug 2019
R.J. Brandt
- 12 A. Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.7.2.4.1]
[ =>]
- 12 J. Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.7.2.4.2]
[ =>]
- 12 M.L. Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.7.2.4.3]
- 12 C.S. Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.7.2.4.4]
[ =>]
- 12 A. Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.7.2.4.1]
- 11 J. Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.7.2.1]
- 10 Elsie Hazel Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.7.3]
b. 31 Oct 1914 d. 15 May 2005
Charles Parrish Callis b. 5 Sep 1915 d. 15 Apr 1995
- 11 M.L. Callis [1.1.1.9.3.8.4.4.7.3.1]
- + D. Buie
- + D. Buie
- 11 M.L. Callis [1.1.1.9.3.8.4.4.7.3.1]
- 10 Mabel Lucille Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.7.4]
b. 10 Sep 1916 d. 5 Nov 2009
- + R. Coons
Earl Elijah Johnson b. 5 Dec 1920 d. 15 May 1988
- 11 C. Johnson [1.1.1.9.3.8.4.4.7.4.1]
- 11 C. Johnson [1.1.1.9.3.8.4.4.7.4.1]
- + R. Coons
- 10 Mary Ellen Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.7.5]
b. 1918 d. Bef 15 May 2005
- 10 Alvin (Corkey) Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.7.6]
b. 1 May 1921 d. 15 May 2005
Edna Imogene Moseley b. 5 Jun 1927 d. 4 Nov 2018
- 11 K. Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.7.6.1]
- 11 Angelee Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.7.6.2]
b. 9 Jul 1946 d. 9 Jul 1946
- 11 Judy Ann Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.7.6.3]
b. 7 May 1947 d. 5 Feb 2016
D.J. Schaefer
- 12 D.J. Schaefer, II [1.1.1.9.3.8.4.4.7.6.3.1]
- 12 L. Schaefer [1.1.1.9.3.8.4.4.7.6.3.2]
- 12 A. Schaefer [1.1.1.9.3.8.4.4.7.6.3.3]
- 12 D.J. Schaefer, II [1.1.1.9.3.8.4.4.7.6.3.1]
- 11 J.D. Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.7.6.4]
- 11 M. Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.7.6.5]
- 11 K. Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.7.6.1]
- 10 Lorene Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.7.7]
b. 12 Nov 1929 d. 24 May 2015
Phillips Doyle Worrell b. 26 Apr 1926 d. 26 Feb 1998
- 11 G.L. Worrell [1.1.1.9.3.8.4.4.7.7.1]
- 11 G.L. Worrell [1.1.1.9.3.8.4.4.7.7.1]
- 10 Cora Ellen Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.7.1]
- 9 August Kurvurul Monroe [1.1.1.9.3.8.4.4.1]
- 8 Elizabeth Monroe [1.1.1.9.3.8.4.5]
b. Abt 1848
- 8 James Monroe [1.1.1.9.3.8.4.6]
b. Abt 1851
- 8 Loretta Monroe [1.1.1.9.3.8.4.7]
b. Abt 1852
- 8 Margaret Monroe [1.1.1.9.3.8.4.8]
b. Abt 1859
- 8 Martha J Monroe [1.1.1.9.3.8.4.1]
- 7 Cyrenia Monroe [1.1.1.9.3.8.5]
b. 3 Jan 1822
N.N.F. (M25)
- 8 Noah Monroe [1.1.1.9.3.8.5.1]
b. 12 Jun 1837
- 8 Noah Monroe [1.1.1.9.3.8.5.1]
- + Charles O Warwick b. 1823
- 7 Orleania Monroe [1.1.1.9.3.8.6]
b. 5 Sep 1823 d. 8 Nov 1849
- 7 Vilania Jane Monroe [1.1.1.9.3.8.7]
b. 5 Jul 1825 d. 4 May 1850
- 7 Isaac John Monroe [1.1.1.9.3.8.8]
b. 1 Sep 1827 d. 21 Mar 1892
- 7 Mary Nervy Monroe [1.1.1.9.3.8.9]
b. 1 Apr 1831 d. 21 Mar 1891
- 7 Almanda Louise Monroe [1.1.1.9.3.8.10]
b. 1 Aug 1833 d. 13 Apr 1900
John Pennington Warwick b. 8 Mar 1835 d. 2 Jan 1895
- 8 Caroline Warwick [1.1.1.9.3.8.10.1]
b. 1855
- 8 Elvin M Warwick [1.1.1.9.3.8.10.2]
b. 28 Mar 1857 d. 13 Aug 1938
- 8 Alexander Z Warwick [1.1.1.9.3.8.10.3]
b. 24 Mar 1858 d. 31 Oct 1940
- + Mary Francis Griffin b. 4 Oct 1861 d. 7 Jan 1946
- + Mary Francis Griffin b. 4 Oct 1861 d. 7 Jan 1946
- 8 Elizabeth Betty Warwick [1.1.1.9.3.8.10.4]
b. 9 Jan 1861 d. 1 Oct 1881
- 8 Elijah L Warwick [1.1.1.9.3.8.10.5]
b. 4 Oct 1863 d. 6 Jan 1933
- 8 Detrus Monroe Warwick [1.1.1.9.3.8.10.6]
b. Oct 1865 d. 19 Jan 1951
- 8 William Albert Warwick [1.1.1.9.3.8.10.7]
b. Jun 1869 d. 14 Jun 1936
- 8 John L Warwick [1.1.1.9.3.8.10.8]
b. 1873
- 8 Caroline Warwick [1.1.1.9.3.8.10.1]
- 7 Elizabeth Sarah Monroe [1.1.1.9.3.8.11]
b. 25 Mar 1836 d. 25 Mar 1901
- 7 William George Monroe [1.1.1.9.3.8.12]
b. 25 Mar 1836 d. 2 Oct 1907
Adeline Atkins b. 30 May 1848 d. 3 Aug 1895
- 8 Horace Maynard Monroe [1.1.1.9.3.8.12.1]
b. 8 Sep 1861 d. 11 Dec 1936
Luzana Elizabeth Graves b. 5 Sep 1865 d. 3 Jan 1890
- 9 Ariebell Monroe [1.1.1.9.3.8.12.1.1]
b. 18 Jul 1885 d. 12 Jul 1966
- 9 William Preston Monroe [1.1.1.9.3.8.12.1.2]
b. 20 Nov 1886 d. 17 Oct 1940
Callie Isabelle Edmondson b. Abt 1891 d. 25 Jun 1964
- 10 Harmon Lawrence Monroe [1.1.1.9.3.8.12.1.2.1]
b. 9 Sep 1909 d. 11 Mar 1991
- 10 Walter Preston Monroe [1.1.1.9.3.8.12.1.2.2]
b. 30 May 1911 d. 25 Apr 1967
Vada E Lynch b. 1 Jul 1911 d. 23 Dec 1993
- 11 E. Monroe [1.1.1.9.3.8.12.1.2.2.1]
- 11 L.D. Monroe [1.1.1.9.3.8.12.1.2.2.2]
- 11 Charles Preston Monroe [1.1.1.9.3.8.12.1.2.2.3]
b. 7 Dec 1934 d. 7 Jul 1941
- 11 E. Monroe [1.1.1.9.3.8.12.1.2.2.1]
- 10 Vada Etta Monroe [1.1.1.9.3.8.12.1.2.3]
b. Abt 1912
Walter P Monroe b. Abt 1912
- 11 L.D. Monroe [1.1.1.9.3.8.12.1.2.3.1]
- 11 L.D. Monroe [1.1.1.9.3.8.12.1.2.3.1]
- 10 Irby Horace Monroe [1.1.1.9.3.8.12.1.2.4]
b. 7 Nov 1912 d. 11 Mar 1991
- 10 Jesse A Monroe [1.1.1.9.3.8.12.1.2.5]
b. Abt 1914
- 10 Harmon Lawrence Monroe [1.1.1.9.3.8.12.1.2.1]
- 9 Richard Sylvester Monroe, MD [1.1.1.9.3.8.12.1.3]
b. 6 Dec 1888 d. 6 Jan 1954
Ella Jane Ousley b. 26 Jun 1892 d. 18 Oct 1977
- 10 Leah Elizabeth Monroe [1.1.1.9.3.8.12.1.3.1]
b. 12 Oct 1914 d. 16 Dec 1981
William C Wolfe b. Abt 1908 d. Yes, date unknown
- 11 J.E. Wolfe [1.1.1.9.3.8.12.1.3.1.1]
- 11 J.E. Wolfe [1.1.1.9.3.8.12.1.3.1.1]
- 10 Eileen Monroe [1.1.1.9.3.8.12.1.3.2]
b. Abt 1917
- 10 Vauda Lee Monroe [1.1.1.9.3.8.12.1.3.3]
b. 14 Jun 1919 d. 30 Oct 2011
Charles H Needham b. 24 Jun 1920 d. 16 Aug 1993
- 11 D.C. Needham [1.1.1.9.3.8.12.1.3.3.1]
- 11 L.L. Needham [1.1.1.9.3.8.12.1.3.3.2]
- 11 D.C. Needham [1.1.1.9.3.8.12.1.3.3.1]
- 10 Leah Elizabeth Monroe [1.1.1.9.3.8.12.1.3.1]
- 9 Ariebell Monroe [1.1.1.9.3.8.12.1.1]
Mary J Gilbert b. 22 Jan 1871 d. 26 May 1939
- 9 Vadie Monroe [1.1.1.9.3.8.12.1.4]
b. Mar 1891 d. 23 Nov 1974
- 9 Iva Monroe [1.1.1.9.3.8.12.1.5]
b. Sep 1892
- 9 George Monroe [1.1.1.9.3.8.12.1.6]
b. 7 Nov 1893 d. Abt 1956
Pauline Victoria Birkenmeyer b. 13 May 1900 d. 12 Oct 1973
- 10 Harold J Monroe [1.1.1.9.3.8.12.1.6.1]
b. 6 Aug 27 d. 31 Jul 1999
- 10 K.P. Monroe [1.1.1.9.3.8.12.1.6.2]
- 10 M.M. Monroe [1.1.1.9.3.8.12.1.6.3]
- 10 Harold J Monroe [1.1.1.9.3.8.12.1.6.1]
- 9 James Monroe [1.1.1.9.3.8.12.1.7]
b. May 1895 d. 30 Dec 1968
- 9 Horace Oda Monroe [1.1.1.9.3.8.12.1.8]
b. 9 Jan 1898 d. 21 Mar 1978
Della Maude Sharp b. 28 Jan 1903 d. 22 Aug 1983
- 10 Naomi Monroe [1.1.1.9.3.8.12.1.8.1]
b. 13 Feb 1919 d. 9 Dec 2009
Richard Pettiebone Campbell, Jr b. 26 Oct 1914 d. 29 May 1995
- 11 R.G. Campbell [1.1.1.9.3.8.12.1.8.1.1]
- 11 Gloria Faye Campbell [1.1.1.9.3.8.12.1.8.1.2]
b. 4 Feb 1942 d. 22 Jan 2014
- 11 J. Campbell [1.1.1.9.3.8.12.1.8.1.3]
- 11 R. Campbell [1.1.1.9.3.8.12.1.8.1.4]
- 11 R.G. Campbell [1.1.1.9.3.8.12.1.8.1.1]
- 10 Roy Parks Monroe [1.1.1.9.3.8.12.1.8.2]
b. 23 Apr 1920 d. 14 May 1996
- 10 Sarah Frances Monroe [1.1.1.9.3.8.12.1.8.3]
b. 16 Mar 1928 d. 31 Aug 2017
- 10 Naomi Monroe [1.1.1.9.3.8.12.1.8.1]
- 9 Biddie Monroe [1.1.1.9.3.8.12.1.9]
b. 23 Jun 1907 d. 24 Jul 1983
- + Wyrick
- + Wyrick
- 9 Ica Scates Monroe [1.1.1.9.3.8.12.1.10]
b. 23 Jun 1907 d. 1 Apr 1951
Coy E Sharp b. 1909 d. 1975
- 9 Vadie Monroe [1.1.1.9.3.8.12.1.4]
- 8 Mary Etter Monroe [1.1.1.9.3.8.12.2]
b. 21 Feb 1868 d. 26 Feb 1926
- 8 Elizabeth Monroe [1.1.1.9.3.8.12.3]
b. 25 Feb 1870 d. 25 Mar 1901
- 8 Eugene Dodge Monroe [1.1.1.9.3.8.12.4]
b. 27 Apr 1872 d. 8 Oct 1937
- 8 Minnie Warren Monroe [1.1.1.9.3.8.12.5]
b. 2 Aug 1874 d. 13 Dec 1972
- 8 James L Monroe [1.1.1.9.3.8.12.6]
b. 23 Jun 1877 d. 23 Sep 1936
- 8 Lillian L Monroe [1.1.1.9.3.8.12.7]
b. 30 Sep 1880 d. 12 May 1973
- 8 Robert Thornburgh Monroe [1.1.1.9.3.8.12.8]
b. 29 Mar 1884 d. Nov 1929
Bertha L Butcher b. 1886
- 9 Cleda Alpha Monroe [1.1.1.9.3.8.12.8.1]
b. 9 Feb 1907 d. 14 Mar 1995
- 9 Claude La Vaughn Monroe [1.1.1.9.3.8.12.8.2]
b. 11 Jul 1909
- 9 Cleda Alpha Monroe [1.1.1.9.3.8.12.8.1]
- 8 Alice Monroe [1.1.1.9.3.8.12.9]
b. 25 Jan 1887 d. 24 Jan 1888
- 8 Milton Tecumseh Monroe [1.1.1.9.3.8.12.10]
b. 18 Apr 1889 d. 13 Aug 1946
- 8 Horace Maynard Monroe [1.1.1.9.3.8.12.1]
- 7 John F Monroe [1.1.1.9.3.8.13]
b. 27 Jun 1839
Ruth Jane Turner b. 6 Dec 1840 d. 12 May 1880
- 8 Nancy Morlena Monroe [1.1.1.9.3.8.13.1]
b. Sep 1858 d. 3 Jan 1905
- 8 Alexander L Monroe [1.1.1.9.3.8.13.2]
b. 2 Feb 1861 d. 26 Apr 1948
- 8 Jacob B Monroe [1.1.1.9.3.8.13.3]
b. Abt 1864 d. 6 Dec 1948
- 8 Nancy Morlena Monroe [1.1.1.9.3.8.13.1]
- 7 Lea Anderson Monroe [1.1.1.9.3.8.1]
- + Temperance Warwick b. 1806
- 6 Nancy Agnes Monroe [1.1.1.9.3.9]
b. 11 Jul 1795 d. 30 Aug 1853
- 6 Martha Monroe [1.1.1.9.3.10]
b. 1800 d. 1835
- 6 George William Monroe [1.1.1.9.3.1]
- 5 Judith Puckett [1.1.1.9.4]
b. 1768
- 5 Phebe Puckett [1.1.1.9.5]
b. 1770 d. 1808
- 5 Elizabeth Betsy Puckett [1.1.1.9.6]
b. 1772 d. 1835
- 5 Drury P Puckett, Jr [1.1.1.9.7]
b. 1777 d. Abt 1817
- 5 Nancy Puckett [1.1.1.9.8]
b. Abt 1778
- 5 Robert Puckett [1.1.1.9.9]
b. 1779 d. May 1860
- 5 George Washington Puckett [1.1.1.9.10]
b. 1789
- 5 George Washington Puckett, Sr [1.1.1.9.1]
- 4 Frances Polly Puckett [1.1.1.1]
- 3 Judith Kirby [1.1.1]
- + John Kirby b. 1675 d. 11 Mar 1795
- 2 Sarah A Williamson [1.1]