


Osage County Cousins
Genealogy for Banks - Parson - Kemple - Mantle - Monroe - Redden - Butler Families

Euphemia Forbes, PM15

( = Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
- 1 Euphemia Forbes, PM15 [1] b. 1553 d. 9 Feb 1641
George Monroe (Munro), II b. 1540 d. 1614
- 2 David Monroe [1.1]
b. 1585 d. 1 Jul 1648
Agnes Munro, of Rev Alexander Munro and Lady Janet Cumming b. 1 Jul 1600 d. 1648
- 3 Andrew Munro [1.1.1]
b. 1625 d. 1668
Elizabeth Alexander b. 1632 d. 1690
- 4 Susannah Monroe [1.1.1.1]
b. 1653 d. 1709
- 4 Elizabeth Monroe [1.1.1.2]
b. 1656
- 4 Mary Monroe [1.1.1.3]
b. 1659 d. 15 Jan 1661
- 4 Andrew Monroe, II [1.1.1.4]
b. 1661 d. 9 Jun 1714
Eleanor Spence b. 1664 d. 1708
- 5 Colonel Andrew Monroe, III [1.1.1.4.1]
b. 1697 d. 27 Mar 1770
Jane Watts b. 1708 d. 21 Dec 1761
- 6 Johnson Monroe [1.1.1.4.1.1]
b. 1719 d. 1790
Rasanna Sarah Harrison b. 1715 d. 1780
- 7 N. Monroe [1.1.1.4.1.1.1]
- 7 Eliza Monroe [1.1.1.4.1.1.2]
b. 1734 d. 1745
- 7 William Thomas Monroe [1.1.1.4.1.1.3]
b. 1740 d. 1769
Mary Smith b. Abt 1744 d. 1794
- 8 John Monroe [1.1.1.4.1.1.3.1]
b. 1760 d. 1833
- 8 Catherine Monroe [1.1.1.4.1.1.3.2]
b. 1761
- 8 Robert S Monroe, Sr [1.1.1.4.1.1.3.3]
b. 1763 d. 6 May 1836
Rosannah Jannie Puckett b. 14 Dec 1766 d. 1845
- 9 George William Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.1]
b. 14 Apr 1782 d. 14 Oct 1869
Margaret Elizabeth Peters b. 1 Jan 1786 d. 14 Sep 1873
- 10 Robert Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.1.1]
b. 1811 d. Aft 1880
Mary Polly Fields b. 1812 d. 8 Mar 1852
- 11 James William Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.1.1.1]
b. Apr 1829 d. 17 Apr 1900
- 11 Mary (Polly) Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.1.1.2]
b. 1830 d. 1831
- 11 Elizabeth Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.1.1.3]
b. 30 Oct 1831 d. 19 Jan 1911
- 11 Louisa Bell Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.1.1.4]
b. 1835 d. 1884
- 11 Elisha Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.1.1.5]
b. 1837 d. 1838
- 11 Mahala Ann Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.1.1.6]
b. 1839 d. 1874
- 11 Elijah Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.1.1.7]
b. 1842 d. 1843
- 11 Sanders Alexander Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.1.1.8]
b. 5 Apr 1843 d. 9 Aug 1887
- 11 William Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.1.1.9]
b. 1846 d. 1847
- 11 Calvin Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.1.1.10]
b. 1848 d. 1849
- 11 Jesse Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.1.1.11]
b. 16 Sep 1850 d. 1851
- 11 George W Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.1.1.12]
b. 1852
- 11 James William Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.1.1.1]
Elizabeth Prudence Mathena b. Apr 1825
- 11 Tobe Alvin Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.1.1.13]
b. 29 Dec 1862 d. 29 Apr 1922
- 11 Tobe Alvin Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.1.1.13]
- 10 Margaret Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.1.2]
b. 1812 d. 24 Dec 1904
Morris R Hardin b. 1814 d. 1841
- 11 S. Hardin [1.1.1.4.1.1.3.3.1.2.1]
- 11 Sarah Elizabeth Hardin [1.1.1.4.1.1.3.3.1.2.2]
b. 31 Jul 1837 d. 6 Feb 1911
- 11 John B Hardin [1.1.1.4.1.1.3.3.1.2.3]
b. 1840
- 11 George W Hardin [1.1.1.4.1.1.3.3.1.2.4]
b. 1841 d. 26 Mar 1863
- 11 S. Hardin [1.1.1.4.1.1.3.3.1.2.1]
- 10 George William Monroe, Jr [1.1.1.4.1.1.3.3.1.3]
b. 1815 d. Bef 1865
Elizabeth Pearson b. 1815 d. 1853
- 11 Jesse Lafayette Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.1.3.1]
b. 7 Feb 1841 d. 22 Feb 1916
- 11 Sherwood M Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.1.3.2]
b. 1842 d. 1875
Ruth Matilda McKeehan b. Feb 1848 d. Abt 1925
- 12 George Washington Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.1.3.2.1]
b. 23 Jun 1864 d. 5 Nov 1946
- 12 Martha Paralee Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.1.3.2.2]
b. 14 Feb 1871 d. 12 Oct 1943
- 12 Samuel Thomas Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.1.3.2.3]
b. 7 Feb 1872 d. 29 Sep 1933
- 12 Elizabeth Belle Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.1.3.2.4]
b. 13 Oct 1873 d. 7 Nov 1960
- 12 George Washington Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.1.3.2.1]
- 11 Samantha J Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.1.3.3]
b. 19 Oct 1845 d. 9 Jul 1908
- 11 Elizabeth Belle Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.1.3.4]
b. 30 Nov 1847 d. 9 Jan 1900
James L McKeehan b. Abt 1847 d. 3 Jul 1917
- 12 Altie Belle McKeehan [1.1.1.4.1.1.3.3.1.3.4.1]
b. 25 Sep 1899 d. 26 Oct 1985
- 12 Altie Belle McKeehan [1.1.1.4.1.1.3.3.1.3.4.1]
- 11 Horace Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.1.3.5]
b. 1849 d. 1860
- 11 Millard F Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.1.3.6]
b. 10 Sep 1852 d. 17 May 1883
- 11 Jesse Lafayette Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.1.3.1]
- + Margaret Simpson b. 21 Jan 1822 d. 26 Mar 1915
- 10 Catherine Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.1.4]
b. 1817 d. Apr 1874
Lide Wiles Dobbs b. 14 Feb 1820 d. 18 May 1862
- 11 Sarah J Dobbs [1.1.1.4.1.1.3.3.1.4.1]
b. 1848
- 11 George Wiles Dobbs [1.1.1.4.1.1.3.3.1.4.2]
b. 1850
- 11 Margaret E Dobbs [1.1.1.4.1.1.3.3.1.4.3]
b. 16 Aug 1850 d. 9 Apr 1925
- 11 George Washington Dobbs [1.1.1.4.1.1.3.3.1.4.4]
b. 16 Sep 1854 d. 29 Feb 1920
- 11 Mary E Dobbs [1.1.1.4.1.1.3.3.1.4.5]
b. 1858
- 11 Sarah J Dobbs [1.1.1.4.1.1.3.3.1.4.1]
- 10 Joseph Marion Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.1.5]
b. 1818 d. 22 Feb 1864
Harriet Newell Davis b. 2 Oct 1829 d. 20 Jul 1898
- 11 Mary E Jane Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.1.5.1]
b. 23 Sep 1848 d. 18 Dec 1885
- 11 William M Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.1.5.2]
b. 4 Feb 1850 d. 25 Dec 1934
- 11 Margaret Elizabeth Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.1.5.3]
b. 4 Feb 1850 d. 30 Sep 1907
- 11 Horace Lee Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.1.5.4]
b. 2 Jun 1856 d. 23 Mar 1934
- 11 Charles B Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.1.5.5]
b. 1857 d. 9 Nov 1914
- 11 Joseph Marion Monroe, Jr [1.1.1.4.1.1.3.3.1.5.6]
b. 1 Dec 1859 d. 14 Jul 1926
- 11 Sarah A Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.1.5.7]
b. 10 Jun 1861 d. 17 Apr 1899
- + W. Lyles
- + W. Lyles
- 11 Elizabeth P ( Betty) Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.1.5.8]
b. 24 Apr 1864 d. 13 Jul 1899
- 11 George W Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.1.5.9]
b. 24 Apr 1864 d. 5 Jan 1936
- 11 Mary E Jane Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.1.5.1]
- 10 Robert Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.1.1]
- 9 Mary (Polly) Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.2]
b. 1785 d. 17 Dec 1819
- + Richard Atkins b. 1788 d. 1836
- + Richard Atkins b. 1788 d. 1836
- 9 Elizabeth Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.3]
b. 5 Dec 1785 d. 7 Dec 1865
Lewis M Atkins b. 5 May 1785 d. 14 Jan 1865
- 10 Margaret Atkins [1.1.1.4.1.1.3.3.3.1]
b. 20 Mar 1805 d. Aft 1850
- + Presley Burnett b. Abt 1802
- + Presley Burnett b. Abt 1802
- 10 Nancy Atkins [1.1.1.4.1.1.3.3.3.2]
b. 4 Nov 1808 d. 1 Jun 1890
Archibald Mullens b. 24 Jan 1805 d. 19 Apr 1890
- 11 E. Mullens [1.1.1.4.1.1.3.3.3.2.1]
- 11 Alvis Mullens [1.1.1.4.1.1.3.3.3.2.2]
b. 5 Jun 1829 d. 15 Sep 1829
- 11 Anna Emeline Mullens [1.1.1.4.1.1.3.3.3.2.3]
b. 1 Jul 1830 d. 24 Feb 1898
W. Marks
- 12 William Henry Marks, Sr [1.1.1.4.1.1.3.3.3.2.3.1]
b. 8 Nov 1865 d. 15 Dec 1933 [ =>]
- 12 William Henry Marks, Sr [1.1.1.4.1.1.3.3.3.2.3.1]
- 11 Elijah Mullens [1.1.1.4.1.1.3.3.3.2.4]
b. 23 Jan 1832 d. 16 Jan 1926
- 11 Sarah Mullens [1.1.1.4.1.1.3.3.3.2.5]
b. 11 Aug 1834 d. 13 Aug 1907
Joel Coffey b. 4 Dec 1826 d. 18 May 1896
- 12 Mary J Coffey [1.1.1.4.1.1.3.3.3.2.5.1]
b. 7 May 1860 d. 24 Aug 1866
- 12 Alta B Coffey [1.1.1.4.1.1.3.3.3.2.5.2]
b. 21 Jul 1871 d. 11 Jul 1880
- 12 Mary J Coffey [1.1.1.4.1.1.3.3.3.2.5.1]
- 11 Elizabeth Mullens [1.1.1.4.1.1.3.3.3.2.6]
b. 7 Oct 1835
- 11 John Mullens, I [1.1.1.4.1.1.3.3.3.2.7]
b. 3 Feb 1838 d. 24 Feb 1928
- 11 Robert Mullens [1.1.1.4.1.1.3.3.3.2.8]
b. 19 Nov 1841 d. 11 Apr 1920
- 11 Julia Louisa Mullens [1.1.1.4.1.1.3.3.3.2.9]
b. 11 Jul 1844 d. Sep 1908
John Henry W McCullin b. 29 Dec 1839 d. 18 Jul 1897
- 12 John Lewis McCullin [1.1.1.4.1.1.3.3.3.2.9.1]
b. 11 Jul 1862 d. 15 Jul 1947
- 12 Emma McCullin [1.1.1.4.1.1.3.3.3.2.9.2]
b. 1864
- 12 Henry Ratliff McCullin [1.1.1.4.1.1.3.3.3.2.9.3]
b. 17 Feb 1864 d. 14 Nov 1938
- 12 William Murray McCullin [1.1.1.4.1.1.3.3.3.2.9.4]
b. 18 Sep 1866 d. 19 Sep 1931
- 12 Willis Murrell McCullin [1.1.1.4.1.1.3.3.3.2.9.5]
b. Abt 1867 d. 14 Nov 1938
- 12 John Lewis McCullin [1.1.1.4.1.1.3.3.3.2.9.1]
- 11 Martha Mullens [1.1.1.4.1.1.3.3.3.2.10]
b. 11 Jun 1847 d. 4 Jun 1909
- 11 Emily Mullens [1.1.1.4.1.1.3.3.3.2.11]
b. 1 Jul 1852 d. 4 Jan 1936
- + Calvin Frost b. 22 Mar 1841 d. 28 Nov 1927
- + Calvin Frost b. 22 Mar 1841 d. 28 Nov 1927
- 11 E. Mullens [1.1.1.4.1.1.3.3.3.2.1]
- 10 Moses Morris Atkins [1.1.1.4.1.1.3.3.3.3]
b. 4 Nov 1808 d. 23 Mar 1859
Mary (Polly) Phipps b. Abt 1806 d. Aft 1850
- 11 Izola Adkins [1.1.1.4.1.1.3.3.3.3.1]
b. Abt 1830 d. Aft 1850
- 11 Elizabeth Atkins [1.1.1.4.1.1.3.3.3.3.2]
b. 1831 d. Aft 1850
- 11 Dellila Atkins [1.1.1.4.1.1.3.3.3.3.3]
b. 1831 d. Abt 1890
- 11 Louisa Adkins [1.1.1.4.1.1.3.3.3.3.4]
b. 19 Mar 1834 d. 25 Apr 1916
- 11 Amanda Adkins [1.1.1.4.1.1.3.3.3.3.5]
b. Abt 1837 d. Aft 1880
- 11 Louis Atkins [1.1.1.4.1.1.3.3.3.3.6]
b. 1849
- 11 Izola Adkins [1.1.1.4.1.1.3.3.3.3.1]
- 10 Nathan Atkins [1.1.1.4.1.1.3.3.3.4]
b. 9 Sep 1811 d. Bef 1850
Anna Needham b. Abt 1811 d. Bef 1850
- 11 Lewis Atkins, Jr [1.1.1.4.1.1.3.3.3.4.1]
b. 26 Sep 1828 d. 10 Mar 1904
- + Elizabeth Jane Atkins b. 26 Jul 1832 d. 8 Mar 1922
- + Elizabeth Jane Atkins b. 26 Jul 1832 d. 8 Mar 1922
- 11 Lurette Adkins [1.1.1.4.1.1.3.3.3.4.2]
b. Abt 1835 d. Bef 1910
Mark M Monroe b. 28 May 1835 d. 19 Jan 1918
- 12 Anna Cordia Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.3.4.2.1]
b. 2 Dec 1854 d. 9 Jan 1932
- 12 Eldridge Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.3.4.2.2]
b. Abt 1857 d. 14 Apr 1950 [ =>]
- 12 Anna Cordia Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.3.4.2.1]
- 11 Ira Atkins [1.1.1.4.1.1.3.3.3.4.3]
b. 24 Jan 1836 d. 4 Mar 1920
- 11 Tolbert Atkins [1.1.1.4.1.1.3.3.3.4.4]
b. Abt 1839
- 11 Lewis Atkins, Jr [1.1.1.4.1.1.3.3.3.4.1]
- 10 Elijah Atkins [1.1.1.4.1.1.3.3.3.5]
b. 4 May 1814 d. 1895
Elizabeth (Betsey) Mullens b. 18 Mar 1813 d. 1866
- 11 Wesley Sylvestor Atkins [1.1.1.4.1.1.3.3.3.5.1]
b. 20 Oct 1836 d. 30 Nov 1916
Emily Catherine Comer b. 27 Aug 1840 d. 1875
- 12 Martha Jane Atkins [1.1.1.4.1.1.3.3.3.5.1.1]
b. 16 Jun 1860 d. 1876
- 12 John Linville Atkins [1.1.1.4.1.1.3.3.3.5.1.2]
b. 8 May 1862 d. 20 Sep 1884
- 12 Rachel Emily Atkins [1.1.1.4.1.1.3.3.3.5.1.3]
b. 7 Feb 1865 d. 1901
- 12 William Wesley Atkins [1.1.1.4.1.1.3.3.3.5.1.4]
b. 5 Nov 1866 d. 9 May 1929
- 12 Elijah L Atkins [1.1.1.4.1.1.3.3.3.5.1.5]
b. 26 Oct 1869 d. 14 Jun 1956
- 12 Col Alonzo 'Lonzo' Atkins [1.1.1.4.1.1.3.3.3.5.1.6]
b. 3 Aug 1873 d. 26 Feb 1928
- 12 Martha Jane Atkins [1.1.1.4.1.1.3.3.3.5.1.1]
Nancy Jane Zachary b. 1 Jan 1847 d. 3 May 1917
- 12 Tilman Cornelius (Tim) Atkins [1.1.1.4.1.1.3.3.3.5.1.7]
b. 31 Jul 1878 d. 24 Aug 1956
- 12 Robert Condee 'Carl' Atkins [1.1.1.4.1.1.3.3.3.5.1.8]
b. 26 Sep 1880 d. 15 Oct 1966
- 12 Minnie M Atkins [1.1.1.4.1.1.3.3.3.5.1.9]
b. 14 Feb 1882 d. Sep 1948
- 12 Joseph Garfield Atkins [1.1.1.4.1.1.3.3.3.5.1.10]
b. 4 Jan 1884 d. 16 Nov 1972 [ =>]
- 12 Charles Thornberg Atkins [1.1.1.4.1.1.3.3.3.5.1.11]
b. 28 Oct 1886 d. 24 Nov 1970 [ =>]
- 12 James Arlie Atkins [1.1.1.4.1.1.3.3.3.5.1.12]
b. 22 Oct 1888 d. 11 Mar 1968 [ =>]
- 12 Tilman Cornelius (Tim) Atkins [1.1.1.4.1.1.3.3.3.5.1.7]
- 11 Wesley Sylvestor Atkins [1.1.1.4.1.1.3.3.3.5.1]
- 10 Robert Rufus Atkins [1.1.1.4.1.1.3.3.3.6]
b. 16 Jan 1816 d. 17 Jan 1892
Pherebe Hill b. 17 Jun 1816 d. 18 Jan 1897
- 11 John Wesley Atkins [1.1.1.4.1.1.3.3.3.6.1]
b. 8 Mar 1838 d. 25 Jan 1883
- 11 Joseph Atkins [1.1.1.4.1.1.3.3.3.6.2]
b. 1840
- 11 Elizabeth Atkins [1.1.1.4.1.1.3.3.3.6.3]
b. 4 Feb 1840 d. 4 Nov 1886
- 11 Nancy A Atkins [1.1.1.4.1.1.3.3.3.6.4]
b. 1842 d. 1 May 1905
- 11 Lewis N Atkins [1.1.1.4.1.1.3.3.3.6.5]
b. 3 Sep 1843 d. 20 Jan 1892
- 11 Tyrissa Jane Adkins [1.1.1.4.1.1.3.3.3.6.6]
b. 1845
- 11 Elisha Atkins [1.1.1.4.1.1.3.3.3.6.7]
b. 1846
- 11 William F Adkins [1.1.1.4.1.1.3.3.3.6.8]
b. Abt 1846 d. Bef 1860
- 11 Adeline Atkins [1.1.1.4.1.1.3.3.3.6.9]
b. 30 May 1848 d. 3 Aug 1895
William George Monroe b. 25 Mar 1836 d. 2 Oct 1907
- 12 Horace Maynard Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.3.6.9.1]
b. 8 Sep 1861 d. 11 Dec 1936 [ =>]
- 12 Mary Etter Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.3.6.9.2]
b. 21 Feb 1868 d. 26 Feb 1926
- 12 Elizabeth Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.3.6.9.3]
b. 25 Feb 1870 d. 25 Mar 1901
- 12 Eugene Dodge Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.3.6.9.4]
b. 27 Apr 1872 d. 8 Oct 1937
- 12 Minnie Warren Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.3.6.9.5]
b. 2 Aug 1874 d. 13 Dec 1972
- 12 James L Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.3.6.9.6]
b. 23 Jun 1877 d. 23 Sep 1936
- 12 Lillian L Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.3.6.9.7]
b. 30 Sep 1880 d. 12 May 1973
- 12 Robert Thornburgh Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.3.6.9.8]
b. 29 Mar 1884 d. Nov 1929 [ =>]
- 12 Alice Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.3.6.9.9]
b. 25 Jan 1887 d. 24 Jan 1888
- 12 Milton Tecumseh Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.3.6.9.10]
b. 18 Apr 1889 d. 13 Aug 1946
- 12 Horace Maynard Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.3.6.9.1]
- 11 Emeline Atkins [1.1.1.4.1.1.3.3.3.6.10]
b. 1849 d. 1878
- 11 John Wesley Atkins [1.1.1.4.1.1.3.3.3.6.1]
- 10 Elizabeth Atkins [1.1.1.4.1.1.3.3.3.7]
b. 17 Jan 1819 d. Aft 1856
James Hubbs b. 1824 d. May 1880
- 11 Fanny Hubbs [1.1.1.4.1.1.3.3.3.7.1]
b. Abt 1849
- 11 Maynard M Hubbs [1.1.1.4.1.1.3.3.3.7.2]
b. 12 Dec 1853 d. 9 Aug 1929
- 11 Thursey Ann Hubbs [1.1.1.4.1.1.3.3.3.7.3]
b. 15 Feb 1854 d. 20 Sep 1938
- 11 Margaret Hubbs [1.1.1.4.1.1.3.3.3.7.4]
b. Abt 1855
- 11 James C Hubbs [1.1.1.4.1.1.3.3.3.7.5]
b. 21 Mar 1859 d. 15 Jul 1888
- 11 Malinda Emmaline Hubbs [1.1.1.4.1.1.3.3.3.7.6]
b. 10 Aug 1861 d. 18 May 1941
- 11 Fanny Hubbs [1.1.1.4.1.1.3.3.3.7.1]
- 10 Mary (Polly) Atkins [1.1.1.4.1.1.3.3.3.8]
b. 17 May 1821 d. Aft 1845
- + John Burnett b. 1812
- + John Burnett b. 1812
- 10 Rachel Atkins [1.1.1.4.1.1.3.3.3.9]
b. 30 Apr 1826 d. 1848
James M Hubbs b. 1824 d. May 1880
- 11 Lewis Hubbs [1.1.1.4.1.1.3.3.3.9.1]
b. Abt 1847 d. Bef 1860
- 11 Rachel Hubbs [1.1.1.4.1.1.3.3.3.9.2]
b. Abt 1848 d. Abt 1871
- 11 Lewis Hubbs [1.1.1.4.1.1.3.3.3.9.1]
- 10 Lewis Atkins, Jr [1.1.1.4.1.1.3.3.3.10]
b. 26 Sep 1828 d. 10 Mar 1904
- + Elizabeth Jane Atkins b. 26 Jul 1832 d. 8 Mar 1922
- + Elizabeth Jane Atkins b. 26 Jul 1832 d. 8 Mar 1922
- 10 Luretta Adkins [1.1.1.4.1.1.3.3.3.11]
b. 1835
- 10 Ira Atkins, I [1.1.1.4.1.1.3.3.3.12]
b. 1837
- 10 Margaret Atkins [1.1.1.4.1.1.3.3.3.1]
- 9 John Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.4]
b. 1786 d. 1860
A.E. Wyrick
- 10 L. Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.4.1]
- 10 R. Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.4.2]
- 10 Pryor L Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.4.3]
b. Abt 1824
- 10 L. Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.4.1]
- 9 Robert Monroe, Jr [1.1.1.4.1.1.3.3.5]
b. 1791 d. 1847
Sarah Sally Burnett b. 1807 d. 1851
- 10 Elisha Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.5.1]
b. 1829 d. 3 Nov 1891
- 10 Calloway Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.5.2]
b. 30 Aug 1831 d. Bef 1870
Sarah Warwick b. 25 Jan 1830 d. 30 May 1897
- 11 Harvey Leroy Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.5.2.1]
b. 6 May 1854 d. 27 Jan 1924
- 11 Perley Jane Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.5.2.2]
b. 1858 d. 19 Oct 1896
- 11 Nancy Frances Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.5.2.3]
b. 1859 d. 6 Jan 1932
- 11 Mary Etter Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.5.2.4]
b. 27 Feb 1860
- 11 William C Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.5.2.5]
b. 1864 d. 16 Feb 1883
- 11 Harvey Leroy Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.5.2.1]
- 10 Enoch Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.5.3]
b. 1833 d. Bef 1880
Elizabeth Graves b. Jun 1832 d. Feb 1904
- 11 Martha J Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.5.3.1]
b. Abt 1859
- 11 Emily Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.5.3.2]
b. Abt 1860
- 11 Tilghman H Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.5.3.3]
b. Abt 1862
- 11 Pearlina Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.5.3.4]
b. Abt 1868
- 11 Barbery Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.5.3.5]
b. Abt 1869
- 11 Ellen Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.5.3.6]
b. Feb 1870 d. 8 Feb 1944
- 11 Martha J Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.5.3.1]
- 10 George Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.5.4]
b. Jun 1834 d. 7 Nov 1913
- 10 Alexander Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.5.5]
b. 1836 d. 1858
- 10 Nathaniel Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.5.6]
b. 1840 d. 17 Jun 1920
- 10 James Henry Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.5.7]
b. 13 Feb 1848 d. 5 Jul 1931
- 10 Elisha Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.5.1]
- 9 Margaret Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.6]
b. 1791 d. 11 Feb 1834
John Wyrick b. 2 Feb 1751
- 10 Jefferson Wyrick [1.1.1.4.1.1.3.3.6.1]
b. 1 Aug 1811
- 10 Jefferson Wyrick [1.1.1.4.1.1.3.3.6.1]
- 9 Barbara Margaret Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.7]
b. 1792 d. 22 Feb 1866
John Kitts b. 1788 d. 7 Oct 1850
- 10 Davidson Kitts [1.1.1.4.1.1.3.3.7.1]
b. 9 Jul 1812 d. 4 Apr 1899
- 10 Solomon Temple Kitts [1.1.1.4.1.1.3.3.7.2]
b. 1813 d. 1880
- 10 Robert Kitts [1.1.1.4.1.1.3.3.7.3]
b. 1816 d. 1880
- 10 Rosanna Kitts [1.1.1.4.1.1.3.3.7.4]
b. Abt 1817
- 10 Margaret Kitts [1.1.1.4.1.1.3.3.7.5]
b. Abt 1818 d. 26 Nov 1879
- 10 Henry Kitts [1.1.1.4.1.1.3.3.7.6]
b. 1822 d. 14 Apr 1916
- 10 Mark Kitts [1.1.1.4.1.1.3.3.7.7]
b. 1823 d. 16 Jun 1863
Margaret A Seviers b. 15 Feb 1824 d. 29 Apr 1905
- 11 Joseph Filmore Kitts [1.1.1.4.1.1.3.3.7.7.1]
b. 28 Oct 1852 d. 25 Mar 1925
Sarah E Price b. 13 Aug 1853 d. 18 Feb 1898
- 12 Margaret Jane Kitts [1.1.1.4.1.1.3.3.7.7.1.1]
b. 16 Oct 1874 d. 14 Oct 1956
- 12 Mary Paralee Kitts [1.1.1.4.1.1.3.3.7.7.1.2]
b. 1878 d. 3 May 1944
- 12 Perlina E Kitts [1.1.1.4.1.1.3.3.7.7.1.3]
b. 21 Jun 1879 d. 27 Aug 1972
- 12 Moses Roy Kitts [1.1.1.4.1.1.3.3.7.7.1.4]
b. 12 Oct 1881 d. 30 Aug 1972
- 12 Nancy Lottie Kitts [1.1.1.4.1.1.3.3.7.7.1.5]
b. 12 Nov 1883 d. 21 Feb 1971
- 12 Victor Hugo Kitts [1.1.1.4.1.1.3.3.7.7.1.6]
b. 26 Feb 1889 d. 21 Sep 1980
- 12 Anna Kitts [1.1.1.4.1.1.3.3.7.7.1.7]
b. 3 Mar 1892 d. 16 May 1919
- 12 Robert J Kitts [1.1.1.4.1.1.3.3.7.7.1.8]
b. 30 Apr 1894 d. 8 Nov 1985 [ =>]
- 12 Margaret Jane Kitts [1.1.1.4.1.1.3.3.7.7.1.1]
Maude L Cardwell b. 21 Sep 1888 d. 10 Dec 1940
- 12 Q. Kitts [1.1.1.4.1.1.3.3.7.7.1.9]
- 12 J. Kitts [1.1.1.4.1.1.3.3.7.7.1.10]
- 12 Joseph Filmore Kitts, Jr [1.1.1.4.1.1.3.3.7.7.1.11]
b. 7 Feb 1868 d. 14 Feb 1951
- 12 Roster Hoyt Kitts [1.1.1.4.1.1.3.3.7.7.1.12]
b. 12 Jun 1907 d. 12 Mar 1926
- 12 Lula Kitts [1.1.1.4.1.1.3.3.7.7.1.13]
b. 14 Aug 1908 d. 7 May 1935
- 12 Bonnie Kate Kitts [1.1.1.4.1.1.3.3.7.7.1.14]
b. Abt 1912 d. 3 Jun 2007
- 12 Hollis Gray Kitts, Sr [1.1.1.4.1.1.3.3.7.7.1.15]
b. 17 Nov 1914 d. 21 Oct 1992 [ =>]
- 12 Pearl Kitts [1.1.1.4.1.1.3.3.7.7.1.16]
b. Abt 1918
- 12 Ruth M Kitts [1.1.1.4.1.1.3.3.7.7.1.17]
b. 22 Jul 1924 d. 21 Oct 2004
- 12 Q. Kitts [1.1.1.4.1.1.3.3.7.7.1.9]
- 11 Barbara Carolyn Kitts [1.1.1.4.1.1.3.3.7.7.2]
b. Jul 1856 d. 1920
- 11 Hansel Menyard Kitts [1.1.1.4.1.1.3.3.7.7.3]
b. 1860 d. 1910
- 11 Solomon Temple Kitts [1.1.1.4.1.1.3.3.7.7.4]
b. 13 Aug 1860 d. 19 Mar 1911
- 11 Joseph Filmore Kitts [1.1.1.4.1.1.3.3.7.7.1]
- 10 Isaac Kitts [1.1.1.4.1.1.3.3.7.8]
b. 1824 d. 1860
- 10 Joseph Wheeler Kitts [1.1.1.4.1.1.3.3.7.9]
b. 5 Jun 1825 d. 1880
- 10 John C Kitts [1.1.1.4.1.1.3.3.7.10]
b. 1826 d. 1924
- 10 George Mark Kitts [1.1.1.4.1.1.3.3.7.11]
b. 1828 d. 12 Jun 1863
- 10 Dicey Ellen Kitts [1.1.1.4.1.1.3.3.7.12]
b. 1829 d. 6 Mar 1946
- 10 Andrew George Kitts [1.1.1.4.1.1.3.3.7.13]
b. 1830 d. 16 Jun 1863
- 10 Edward Caswell Kitts [1.1.1.4.1.1.3.3.7.14]
b. Jan 1834 d. 24 Mar 1924
Margaret Susan Colvin b. Mar 1834 d. Nov 1910
- 11 Martha Kitts [1.1.1.4.1.1.3.3.7.14.1]
b. 1853
- 11 Barbara Ann Kitts [1.1.1.4.1.1.3.3.7.14.2]
b. 4 Nov 1857 d. 1 Feb 1931
- 11 Lucinda Jane Kitts [1.1.1.4.1.1.3.3.7.14.3]
b. 1859
- 11 Cordelia Cinthia Kitts [1.1.1.4.1.1.3.3.7.14.4]
b. 29 May 1860 d. 19 Apr 1880
- 11 Martha Kitts [1.1.1.4.1.1.3.3.7.14.1]
- 10 Sterling Huston Kitts [1.1.1.4.1.1.3.3.7.15]
b. 10 Jul 1835 d. 20 Mar 1924
- 10 Polly Kitts [1.1.1.4.1.1.3.3.7.16]
b. 1845
- 10 Davidson Kitts [1.1.1.4.1.1.3.3.7.1]
- 9 Marcus Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8]
b. 3 Aug 1793 d. 6 Sep 1870
Nancy Davis b. 14 Jul 1795 d. 8 Aug 1853
- 10 Lea Anderson Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1]
b. 13 May 1815 d. 1887
Nancy Atkins b. 4 Apr 1815 d. 14 Jun 1889
- 11 Mark M Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1.1]
b. 28 May 1835 d. 19 Jan 1918
Lurette Adkins b. Abt 1835 d. Bef 1910
- 12 Anna Cordia Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1.1.1]
b. 2 Dec 1854 d. 9 Jan 1932
- 12 Eldridge Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1.1.2]
b. Abt 1857 d. 14 Apr 1950 [ =>]
- 12 Anna Cordia Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1.1.1]
Sarah Harrison b. Abt 1850 d. 16 Sep 1882
- 12 Arlee G Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1.1.3]
b. Apr 1867 d. 1947
- 12 Vilance Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1.1.4]
b. 1874
- 12 Mary Etta Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1.1.5]
b. 30 May 1874
- 12 Matilda Roberta Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1.1.6]
b. Nov 1879 d. 25 Nov 1968
- 12 Arlee G Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1.1.3]
Nancy E Dyer b. 2 Oct 1849 d. 10 Mar 1889
- 12 Amanda Tennessee Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1.1.7]
b. 11 Oct 1884 d. 21 Jan 1891
- 12 Amanda Tennessee Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1.1.7]
Emily Jones b. Abt 1860 d. 5 Jul 1920
- 12 Horace Leonard Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1.1.8]
b. 5 Jun 1890 d. Sep 1970
- 12 Horace Leonard Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1.1.8]
- 11 Margaret Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1.2]
b. 1838 d. 11 Aug 1904
- 11 Martin V Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1.3]
b. Aug 1838 d. 24 Oct 1914
- 11 Louisa Jane Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1.4]
b. 17 Jun 1839 d. 18 Aug 1913
Thomas Brooks McMillin b. 19 Jul 1834 d. 7 Dec 1864
- 12 James Morgan McMillin [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1.4.1]
b. 1 Jul 1859 d. 31 Aug 1934 [ =>]
- 12 Infant McMillin [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1.4.2]
b. 3 Mar 1863 d. 22 Feb 1864
- 12 James Morgan McMillin [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1.4.1]
Noah Roark b. 13 Jun 1832 d. 11 Mar 1898
- 12 Rella Randolph Roark [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1.4.3]
b. 5 Dec 1867 d. 15 Nov 1966 [ =>]
- 12 William Monroe Roark [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1.4.4]
b. 17 Dec 1873 d. 12 Apr 1926
- 12 Rella Randolph Roark [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1.4.3]
- 11 Mary Addie Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1.5]
b. 1842 d. Between 1843 and 1936
- 11 James Calvin Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1.6]
b. 21 Apr 1844 d. 9 Jan 1909
Mary Ann Shadwick b. 11 Feb 1853 d. 14 May 1947
- 12 Alfred Edwin Monroe, MD [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1.6.1]
b. 10 Apr 1870 d. 30 Jun 1954 [ =>]
- 12 Nevada Elizabeth Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1.6.2]
b. 5 Aug 1872 d. 1 Apr 1947
- 12 Mary Melcenia Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1.6.3]
b. 27 Sep 1875 d. 16 Mar 1949 [ =>]
- 12 William Alfred Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1.6.4]
b. 30 Nov 1877 d. 26 May 1878
- 12 George Calvin Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1.6.5]
b. 23 Oct 1879 d. 15 Mar 1966 [ =>]
- 12 Lillie Maude Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1.6.6]
b. 16 Jul 1882 d. 15 Aug 1974 [ =>]
- 12 Ulysses Sidney Monroe, MD [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1.6.7]
b. 14 Nov 1885 d. 15 Apr 1961 [ =>]
- 12 Emmett Harrison Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1.6.8]
b. 9 Feb 1889 d. 2 Aug 1962
- 12 Nancy Ann Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1.6.9]
b. 20 Mar 1892 d. 22 Apr 1916 [ =>]
- 12 Alfred Edwin Monroe, MD [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1.6.1]
- 11 Tildon Howard Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1.7]
b. Jul 1847 d. 8 Apr 1936
Malderene M Neil b. Apr 1852 d. 12 Apr 1927
- 12 Leona A Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1.7.1]
b. 1868 d. 3 Mar 1923
- 12 Sam Melton Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1.7.2]
b. 26 Dec 1868 d. 29 Mar 1956 [ =>]
- 12 Nancy Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1.7.3]
b. Abt 1871
- 12 McFarland F Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1.7.4]
b. 26 Jul 1873 d. 7 Jul 1945
- 12 James Albert Clark Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1.7.5]
b. 3 Oct 1873 d. 11 Nov 1964
- 12 Albert Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1.7.6]
b. Oct 1876
- 12 David Edgar Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1.7.7]
b. 22 Apr 1878 d. 26 Jun 1959
- 12 Martha Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1.7.8]
b. 26 Apr 1884 d. 7 Aug 1955
- 12 George Emerson Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1.7.9]
b. 16 May 1888 d. 4 Dec 1967
- 12 Owen Oscar Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1.7.10]
b. 1 Aug 1889 d. 2 Jul 1966
- 12 Ruel L Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1.7.11]
b. 27 Jun 1894 d. 25 Jul 1980
- 12 Myrtle Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1.7.12]
b. Jul 1895
- 12 Leona A Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1.7.1]
- 11 Woodson Taylor Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1.8]
b. 13 Jan 1848 d. 30 Apr 1930
- 11 William George Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1.9]
b. 1849 d. 1896
- 11 Lucinda Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1.10]
b. 1853
- 11 Lee Anderson Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1.11]
b. May 1854 d. 27 Jan 1924
- 11 Mark M Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1.1]
- 10 Lucinda Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.2]
b. 27 Apr 1816 d. 14 Oct 1871
- 10 Calvin Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.3]
b. 22 May 1818 d. 7 Feb 1871
- 10 James L Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.4]
b. 30 Mar 1820 d. 23 Sep 1936
Margaret Bryan b. 1824 d. Aft 1870
- 11 Martha J Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.4.1]
b. 1843 d. Yes, date unknown
- 11 Hester Ann Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.4.2]
b. Abt 1844
- 11 Elvina Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.4.3]
b. Abt 1846
- 11 Alexander Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.4.4]
b. 19 Mar 1846 d. 29 Jul 1926
Martha Jane Miller b. 22 Apr 1845 d. 22 Apr 1920
- 12 August Kurvurul Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.4.4.1]
b. 21 Dec 1867 d. 21 Apr 1931 [ =>]
- 12 James Lycircus Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.4.4.2]
b. 22 May 1870 d. 2 Apr 1958 [ =>]
- 12 Adam Aquilla Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.4.4.3]
b. 28 May 1872 d. 14 Jul 1949 [ =>]
- 12 Horace Maynard (Maine) Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.4.4.4]
b. 30 Jan 1875 d. 29 Apr 1956 [ =>]
- 12 Addison Jones (Doc) Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.4.4.5]
b. 10 Oct 1877 d. 29 Jan 1928 [ =>]
- 12 Louis Edward Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.4.4.6]
b. 2 Jun 1880 d. 31 Jan 1965
- 12 Marcus J Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.4.4.7]
b. 30 Jul 1884 d. 13 Oct 1970 [ =>]
- 12 August Kurvurul Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.4.4.1]
- 11 Elizabeth Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.4.5]
b. Abt 1848
- 11 James Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.4.6]
b. Abt 1851
- 11 Loretta Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.4.7]
b. Abt 1852
- 11 Margaret Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.4.8]
b. Abt 1859
- 11 Martha J Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.4.1]
- 10 Cyrenia Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.5]
b. 3 Jan 1822
N.N.F. (M25)
- 11 Noah Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.5.1]
b. 12 Jun 1837
- 11 Noah Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.5.1]
- + Charles O Warwick b. 1823
- 10 Orleania Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.6]
b. 5 Sep 1823 d. 8 Nov 1849
- 10 Vilania Jane Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.7]
b. 5 Jul 1825 d. 4 May 1850
- 10 Isaac John Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.8]
b. 1 Sep 1827 d. 21 Mar 1892
- 10 Mary Nervy Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.9]
b. 1 Apr 1831 d. 21 Mar 1891
- 10 Almanda Louise Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.10]
b. 1 Aug 1833 d. 13 Apr 1900
John Pennington Warwick b. 8 Mar 1835 d. 2 Jan 1895
- 11 Caroline Warwick [1.1.1.4.1.1.3.3.8.10.1]
b. 1855
- 11 Elvin M Warwick [1.1.1.4.1.1.3.3.8.10.2]
b. 28 Mar 1857 d. 13 Aug 1938
- 11 Alexander Z Warwick [1.1.1.4.1.1.3.3.8.10.3]
b. 24 Mar 1858 d. 31 Oct 1940
- + Mary Francis Griffin b. 4 Oct 1861 d. 7 Jan 1946
- + Mary Francis Griffin b. 4 Oct 1861 d. 7 Jan 1946
- 11 Elizabeth Betty Warwick [1.1.1.4.1.1.3.3.8.10.4]
b. 9 Jan 1861 d. 1 Oct 1881
- 11 Elijah L Warwick [1.1.1.4.1.1.3.3.8.10.5]
b. 4 Oct 1863 d. 6 Jan 1933
- 11 Detrus Monroe Warwick [1.1.1.4.1.1.3.3.8.10.6]
b. Oct 1865 d. 19 Jan 1951
- 11 William Albert Warwick [1.1.1.4.1.1.3.3.8.10.7]
b. Jun 1869 d. 14 Jun 1936
- 11 John L Warwick [1.1.1.4.1.1.3.3.8.10.8]
b. 1873
- 11 Caroline Warwick [1.1.1.4.1.1.3.3.8.10.1]
- 10 Elizabeth Sarah Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.11]
b. 25 Mar 1836 d. 25 Mar 1901
- 10 William George Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.12]
b. 25 Mar 1836 d. 2 Oct 1907
Adeline Atkins b. 30 May 1848 d. 3 Aug 1895
- 11 Horace Maynard Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.12.1]
b. 8 Sep 1861 d. 11 Dec 1936
Luzana Elizabeth Graves b. 5 Sep 1865 d. 3 Jan 1890
- 12 Ariebell Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.12.1.1]
b. 18 Jul 1885 d. 12 Jul 1966
- 12 William Preston Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.12.1.2]
b. 20 Nov 1886 d. 17 Oct 1940 [ =>]
- 12 Richard Sylvester Monroe, MD [1.1.1.4.1.1.3.3.8.12.1.3]
b. 6 Dec 1888 d. 6 Jan 1954 [ =>]
- 12 Ariebell Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.12.1.1]
Mary J Gilbert b. 22 Jan 1871 d. 26 May 1939
- 12 Vadie Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.12.1.4]
b. Mar 1891 d. 23 Nov 1974
- 12 Iva Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.12.1.5]
b. Sep 1892
- 12 George Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.12.1.6]
b. 7 Nov 1893 d. Abt 1956 [ =>]
- 12 James Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.12.1.7]
b. May 1895 d. 30 Dec 1968
- 12 Horace Oda Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.12.1.8]
b. 9 Jan 1898 d. 21 Mar 1978 [ =>]
- 12 Biddie Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.12.1.9]
b. 23 Jun 1907 d. 24 Jul 1983
- 12 Ica Scates Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.12.1.10]
b. 23 Jun 1907 d. 1 Apr 1951 [ =>]
- 12 Vadie Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.12.1.4]
- 11 Mary Etter Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.12.2]
b. 21 Feb 1868 d. 26 Feb 1926
- 11 Elizabeth Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.12.3]
b. 25 Feb 1870 d. 25 Mar 1901
- 11 Eugene Dodge Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.12.4]
b. 27 Apr 1872 d. 8 Oct 1937
- 11 Minnie Warren Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.12.5]
b. 2 Aug 1874 d. 13 Dec 1972
- 11 James L Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.12.6]
b. 23 Jun 1877 d. 23 Sep 1936
- 11 Lillian L Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.12.7]
b. 30 Sep 1880 d. 12 May 1973
- 11 Robert Thornburgh Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.12.8]
b. 29 Mar 1884 d. Nov 1929
Bertha L Butcher b. 1886
- 12 Cleda Alpha Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.12.8.1]
b. 9 Feb 1907 d. 14 Mar 1995
- 12 Claude La Vaughn Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.12.8.2]
b. 11 Jul 1909
- 12 Cleda Alpha Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.12.8.1]
- 11 Alice Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.12.9]
b. 25 Jan 1887 d. 24 Jan 1888
- 11 Milton Tecumseh Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.12.10]
b. 18 Apr 1889 d. 13 Aug 1946
- 11 Horace Maynard Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.12.1]
- 10 John F Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.13]
b. 27 Jun 1839
Ruth Jane Turner b. 6 Dec 1840 d. 12 May 1880
- 11 Nancy Morlena Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.13.1]
b. Sep 1858 d. 3 Jan 1905
- 11 Alexander L Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.13.2]
b. 2 Feb 1861 d. 26 Apr 1948
- 11 Jacob B Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.13.3]
b. Abt 1864 d. 6 Dec 1948
- 11 Nancy Morlena Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.13.1]
- 10 Lea Anderson Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.8.1]
- + Temperance Warwick b. 1806
- 9 Nancy Agnes Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.9]
b. 11 Jul 1795 d. 30 Aug 1853
- 9 Martha Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.10]
b. 1800 d. 1835
- 9 George William Monroe [1.1.1.4.1.1.3.3.1]
- 8 James Monroe [1.1.1.4.1.1.3.4]
b. 1766 d. 1840
- + Sally Sarah Crews b. 1766 d. 17 May 1856
- + Sally Sarah Crews b. 1766 d. 17 May 1856
- 8 Elizabeth Monroe [1.1.1.4.1.1.3.5]
b. 1768
- 8 John Monroe [1.1.1.4.1.1.3.1]
- 7 Johnson Monroe [1.1.1.4.1.1.4]
b. 1744 d. 16 Sep 1829
- 7 N. Monroe [1.1.1.4.1.1.1]
- 6 Elinor Monroe [1.1.1.4.1.2]
b. 1720 d. 1754
- 6 George Monroe [1.1.1.4.1.3]
b. 1725 d. 24 Feb 1789
- 6 Jane Monroe [1.1.1.4.1.4]
b. 1728 d. 10 Mar 1815
- 6 John Monroe [1.1.1.4.1.5]
b. 1730 d. 5 Feb 1767
- 6 Johnson Monroe [1.1.1.4.1.1]
- 5 Colonel Andrew Monroe, III [1.1.1.4.1]
- 4 George Monroe [1.1.1.5]
b. 1663 d. 1668
- 4 William Gent Monroe [1.1.1.6]
b. 1666 d. 30 Mar 1737
- 4 Susannah Monroe [1.1.1.1]
- 3 Andrew Munro [1.1.1]
- 2 David Monroe [1.1]