


Osage County Cousins
Genealogy for Banks - Parson - Kemple - Mantle - Monroe - Redden - Butler Families

Hannah Goodenow

( = Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
- 1 Hannah Goodenow [1] b. 28 Nov 1639 d. 5 Apr 1688
- 2 Caleb F Pendleton [1.1]
b. 8 Aug 1669 d. 19 Mar 1746
- 3 Bryant "Brian" Pendleton [1.1.1]
b. 15 Jun 1701 d. 1752
Anne Wilcox b. 14 Jun 1701 d. 1751
- 4 Lois Pendleton [1.1.1.1]
b. 1745 d. 13 Oct 1843
Abraham Covalt b. 8 Aug 1742 d. 30 Mar 1791
- 5 Timothy Isaac Covalt [1.1.1.1.1]
b. 14 Feb 1766 d. 14 Aug 1845
Sarah Bowen b. 13 Nov 1771 d. 12 Jan 1859
- 6 Bowen Covault [1.1.1.1.1.1]
b. 1786
- 6 Abraham Covault [1.1.1.1.1.2]
b. 30 Nov 1790 d. 17 Mar 1875
- 6 Sarah Covault [1.1.1.1.1.3]
b. 1792
- 6 Nancy Covault [1.1.1.1.1.4]
b. 8 Feb 1793 d. 28 May 1844
John Parson b. 5 Apr 1784 d. 1 Oct 1846
- 7 S. Parsons [1.1.1.1.1.4.1]
- 7 Abner Parson [1.1.1.1.1.4.2]
b. Abt 1810 d. Aft 1862
America Kiplinger b. 19 Mar 1810 d. Abt 1840
- 8 Frances Marion (F M) Parson [1.1.1.1.1.4.2.1]
b. Abt 1837 d. Yes, date unknown
- 8 Frances Marion (F M) Parson [1.1.1.1.1.4.2.1]
Sarah Dulany b. Abt 1822 d. 4 Jul 1869
- 8 John Perry Parson [1.1.1.1.1.4.2.2]
b. 19 Jul 1841 d. 22 Mar 1926
L. _____
- 9 C. Parson [1.1.1.1.1.4.2.2.1]
W. Moore
- 10 N. Moore [1.1.1.1.1.4.2.2.1.1]
- 10 Harry Moore [1.1.1.1.1.4.2.2.1.2]
b. 1885
- 10 N. Moore [1.1.1.1.1.4.2.2.1.1]
- 9 Jodie Parson [1.1.1.1.1.4.2.2.2]
- 9 C. Parson [1.1.1.1.1.4.2.2.1]
- + N.M. Laymon
- + N.M. Laymon
- 8 Dennis Charm Parson [1.1.1.1.1.4.2.3]
b. Abt 1844 d. Yes, date unknown
- 8 Rhoda Elizabeth Parson [1.1.1.1.1.4.2.4]
b. 27 Jan 1846 d. 25 Jun 1932
Henry G Uhler b. Abt 1841 d. 1902
- 9 Etta Uhler [1.1.1.1.1.4.2.4.1]
b. Abt 1866 d. 13 Nov 1928
Alfred R Hickman b. Abt 1854 d. Yes, date unknown
- 10 Henry Everett Hickman [1.1.1.1.1.4.2.4.1.1]
b. 6 Sep 1896 d. Yes, date unknown
Pearl May Rogers b. 10 May 1907 d. 27 Oct 1991
- 11 K.L. Hickman [1.1.1.1.1.4.2.4.1.1.1]
- 11 K.L. Hickman [1.1.1.1.1.4.2.4.1.1.1]
- 10 Henry Everett Hickman [1.1.1.1.1.4.2.4.1.1]
- 9 Lucinda Rebecca Uhler [1.1.1.1.1.4.2.4.2]
b. Abt 1867 d. 2 Mar 1941
James Edmund Mulvihill b. 8 Mar 1862 d. Apr 1930
- 10 James Isaac Mulvihill [1.1.1.1.1.4.2.4.2.1]
b. 9 Jul 1899 d. 13 Jul 1954
- 10 Daniel William Mulvihill [1.1.1.1.1.4.2.4.2.2]
b. 20 Apr 1902 d. 7 Jan 1983
- 10 Sarah Kathryn Mulvihill [1.1.1.1.1.4.2.4.2.3]
b. Abt 1903 d. 18 Jul 1981
- 10 James Isaac Mulvihill [1.1.1.1.1.4.2.4.2.1]
- 9 Sarah Alice Uhler [1.1.1.1.1.4.2.4.3]
b. Abt 1869 d. 18 Oct 1919
Preston Dark b. 26 Sep 1859 d. 13 Mar 1945
- 10 Henry Dark [1.1.1.1.1.4.2.4.3.1]
b. 12 Nov 1897 d. Yes, date unknown
- 10 Etta Marie Dark [1.1.1.1.1.4.2.4.3.2]
b. 15 Nov 1901 d. 20 Jun 1923
George Howard Jones b. 4 Mar 1902 d. 5 Jun 1963
- 11 Alice Janettie Jones [1.1.1.1.1.4.2.4.3.2.1]
b. 13 Jun 1923 d. 18 Apr 2015
Bobby Wilson Harford b. 28 Mar 1924 d. 21 May 1998
- 12 P. Harford [1.1.1.1.1.4.2.4.3.2.1.1]
- 12 S. Harford [1.1.1.1.1.4.2.4.3.2.1.2]
- 12 P. Harford [1.1.1.1.1.4.2.4.3.2.1.1]
- 11 Alice Janettie Jones [1.1.1.1.1.4.2.4.3.2.1]
- 10 Ruby Dark [1.1.1.1.1.4.2.4.3.3]
b. 31 May 1904 d. Mar 1989
H. Baker
- + Art Hopkins d. Yes, date unknown
- 10 Henry Dark [1.1.1.1.1.4.2.4.3.1]
- 9 Mary J Uhler [1.1.1.1.1.4.2.4.4]
b. Abt 1871
- 9 Bertha A Uhler [1.1.1.1.1.4.2.4.5]
b. Abt 1874 d. 2 May 1922
- + Harry B Shepherd b. Abt 1855 d. 28 Nov 1940
- + Harry B Shepherd b. Abt 1855 d. 28 Nov 1940
- 9 Emma L Uhler [1.1.1.1.1.4.2.4.6]
b. Abt 1879 d. 9 Sep 1951
- + Frank Lindsay Loder b. 12 Sep 1881 d. 11 Jul 1968
- + Frank Lindsay Loder b. 12 Sep 1881 d. 11 Jul 1968
- 9 Walter Uhler [1.1.1.1.1.4.2.4.7]
b. Aug 1882 d. 29 Jan 1964
- 9 Etta Uhler [1.1.1.1.1.4.2.4.1]
- 8 Joseph Henry Parson [1.1.1.1.1.4.2.5]
b. 9 Sep 1847 d. 17 Sep 1935
Mariah A Cook b. 6 Feb 1848 d. 17 Aug 1924
- 9 Albert Parson [1.1.1.1.1.4.2.5.1]
b. Abt 1874
- 9 Tressie Parson [1.1.1.1.1.4.2.5.2]
b. Abt 1886 d. Yes, date unknown
- 9 Bessie Parson [1.1.1.1.1.4.2.5.3]
b. 30 Oct 1886 d. 26 Feb 1948
- 9 Minnie E Parson [1.1.1.1.1.4.2.5.4]
b. 14 Aug 1887 d. 13 Jun 1944
- + Eldo D Hackerd b. 25 Jun 1880 d. 8 Sep 1945
- + Eldo D Hackerd b. 25 Jun 1880 d. 8 Sep 1945
- 9 Albert Parson [1.1.1.1.1.4.2.5.1]
- 8 Sarah Abigail Parson [1.1.1.1.1.4.2.6]
b. 20 Apr 1848 d. 18 Dec 1916
Nathan Daniel McKee b. 21 Aug 1847 d. 25 Jul 1918
- 9 Artimas Samil (Artie) McKee [1.1.1.1.1.4.2.6.1]
b. 8 Nov 1868 d. 16 Jun 1955
Florence Nightengale McCalla b. 11 Sep 1880 d. 1 Mar 1971
- 10 William Done McKee [1.1.1.1.1.4.2.6.1.1]
b. 12 Feb 1900 d. 5 Apr 1964
- 10 Alvie Emery McKee [1.1.1.1.1.4.2.6.1.2]
b. 7 Oct 1901 d. 10 Apr 1974
Hazel Elizabeth Hamilton b. 21 Mar 1906 d. 19 Nov 1979
- 11 Jackie Lee McKee [1.1.1.1.1.4.2.6.1.2.1]
b. 7 Jan 1939 d. 12 Feb 1989
- 11 Jackie Lee McKee [1.1.1.1.1.4.2.6.1.2.1]
- 10 Thomas Leroy McKee [1.1.1.1.1.4.2.6.1.3]
b. 9 Aug 1903 d. 17 Jun 1981
- + Lydia R Rowe b. 21 Aug 1898 d. 13 Jun 1981
- + Lydia R Rowe b. 21 Aug 1898 d. 13 Jun 1981
- 10 Lyman Amos McKee [1.1.1.1.1.4.2.6.1.4]
b. 5 Oct 1906 d. 27 Nov 1998
- + Hilda Seidler b. 31 Jul 1910 d. 19 Oct 2006
- + Hilda Seidler b. 31 Jul 1910 d. 19 Oct 2006
- 10 Shellie Artie McKee [1.1.1.1.1.4.2.6.1.5]
b. 24 Feb 1910 d. 26 Sep 1925
- 10 Lonnie Ira McKee [1.1.1.1.1.4.2.6.1.6]
b. 12 Mar 1914 d. 15 Oct 1982
Jennie Ellen Davis b. 22 Jun 1915 d. 27 Aug 1983
- 11 Shelley Hubert McKee [1.1.1.1.1.4.2.6.1.6.1]
b. 28 Jul 1939 d. 18 Nov 2015
- 11 Donald Frank McKee [1.1.1.1.1.4.2.6.1.6.2]
b. 15 Dec 1941 d. 5 Nov 2008
D.S. Stout
- 12 D.P. McKee [1.1.1.1.1.4.2.6.1.6.2.1]
- 12 D.P. McKee [1.1.1.1.1.4.2.6.1.6.2.1]
- 11 Lonnie Ray (Mack) McKee [1.1.1.1.1.4.2.6.1.6.3]
b. 26 Jun 1945 d. 22 Oct 2007
- 11 F.L. McKee [1.1.1.1.1.4.2.6.1.6.4]
- 11 Shelley Hubert McKee [1.1.1.1.1.4.2.6.1.6.1]
- 10 Wayne Edward McKee [1.1.1.1.1.4.2.6.1.7]
b. 29 Oct 1916 d. 17 Jun 1988
- 10 Estella Josephine McKee [1.1.1.1.1.4.2.6.1.8]
b. 24 Nov 1918 d. 27 Apr 1993
- + Carl Cantor b. 7 May 1913 d. 16 May 1992
- + Carl Cantor b. 7 May 1913 d. 16 May 1992
- 10 Alberta Cornelius McKee [1.1.1.1.1.4.2.6.1.9]
b. 11 Mar 1922 d. 11 Mar 1922
- 10 William Done McKee [1.1.1.1.1.4.2.6.1.1]
- 9 Matilda Evelina McKee [1.1.1.1.1.4.2.6.2]
b. 18 Mar 1872 d. 24 Jan 1874
- 9 Clementine Leonidas McKee [1.1.1.1.1.4.2.6.3]
b. 17 Aug 1874 d. 6 Sep 1874
- 9 Olive Estella McKee [1.1.1.1.1.4.2.6.4]
b. 19 Jul 1876 d. Oct 1977
William Leroy Miller b. 10 Oct 1869 d. 5 Mar 1951
- 10 Kester Leroy Miller [1.1.1.1.1.4.2.6.4.1]
b. 25 Jun 1897 d. 17 Jan 1982
Lauree Margaret Ragan b. 16 Oct 1903 d. 17 Sep 1985
- 10 Maria V Miller [1.1.1.1.1.4.2.6.4.2]
b. Abt 1900 d. Aft 1982
- 10 Rena B Miller [1.1.1.1.1.4.2.6.4.3]
b. 22 Sep 1903 d. 3 Aug 1993
- 10 Agnes F Miller [1.1.1.1.1.4.2.6.4.4]
b. 29 Jun 1907 d. 29 Oct 1948
- 10 Byron G Miller [1.1.1.1.1.4.2.6.4.5]
b. 20 Apr 1908 d. 3 Apr 1992
Elma Bessie Rowlett b. 18 Aug 1907 d. 10 Jul 1999
- 11 Jo Anne Miller [1.1.1.1.1.4.2.6.4.5.1]
b. 25 Oct 1932 d. 8 Nov 2017
- 11 Wanda Lou Miller [1.1.1.1.1.4.2.6.4.5.2]
b. 25 Jul 1935 d. 27 Sep 2017
- 11 Rodney Leon Miller [1.1.1.1.1.4.2.6.4.5.3]
b. 20 Jun 1939 d. 17 Oct 2013
- 11 K.G. Miller [1.1.1.1.1.4.2.6.4.5.4]
- 11 Jo Anne Miller [1.1.1.1.1.4.2.6.4.5.1]
- 10 Kester Leroy Miller [1.1.1.1.1.4.2.6.4.1]
- 9 Etta McKee [1.1.1.1.1.4.2.6.5]
b. Apr 1880 d. Yes, date unknown
- 9 Deniece Susette McKee [1.1.1.1.1.4.2.6.6]
b. 2 Sep 1880 d. 29 Jan 1940
Charles Dumons Olmsted b. 25 Jun 1878 d. 25 May 1956
- 10 Deniece Delila Olmstead [1.1.1.1.1.4.2.6.6.1]
b. Abt 1904 d. 1959
- 10 Lester L Olmstead [1.1.1.1.1.4.2.6.6.2]
b. 22 Oct 1904 d. 26 Mar 1990
Ruth Lucille Harmon b. 9 May 1912 d. Mar 1989
- 11 Barbara Kay Olmsted [1.1.1.1.1.4.2.6.6.2.1]
b. 4 Aug 1939 d. 15 Nov 1988
- 11 Barbara Kay Olmsted [1.1.1.1.1.4.2.6.6.2.1]
- 10 Norma May Olmsted [1.1.1.1.1.4.2.6.6.3]
b. 23 Apr 1906 d. 15 Jul 1975
- 10 Gladys Lillie Olmstead [1.1.1.1.1.4.2.6.6.4]
b. 19 Jan 1908 d. Dec 1992
- 10 Genevieve Rose Olmstead [1.1.1.1.1.4.2.6.6.5]
b. 2 Sep 1909 d. 5 Jan 1996
- 10 Viola Lucille Olmsted [1.1.1.1.1.4.2.6.6.6]
b. 26 Apr 1911 d. 31 Jan 1966
Francis Benenezette Byram b. 14 Apr 1903 d. 14 Feb 1954
- 11 Elva Susanna Byram [1.1.1.1.1.4.2.6.6.6.1]
b. 14 Jan 1932 d. 3 Feb 2011
- 11 Robert Francis Byram [1.1.1.1.1.4.2.6.6.6.2]
b. 3 Aug 1933 d. 15 Sep 1999
- 11 Ralph Ray Byram [1.1.1.1.1.4.2.6.6.6.3]
b. 14 Jan 1936 d. 29 Sep 2013
- 11 E.B. Byram [1.1.1.1.1.4.2.6.6.6.4]
- 11 A.C. Byram [1.1.1.1.1.4.2.6.6.6.5]
- 11 Elva Susanna Byram [1.1.1.1.1.4.2.6.6.6.1]
- 10 Nathan D Olmsted [1.1.1.1.1.4.2.6.6.7]
b. 21 Dec 1913 d. Dec 1972
- 10 Eba Lavina Olmsted [1.1.1.1.1.4.2.6.6.8]
b. 10 Aug 1916 d. 30 Apr 2001
Ernest Leroy Stoumbaugh b. 27 Feb 1915 d. 17 May 1957
- 11 Richard Lee Stoumbaugh [1.1.1.1.1.4.2.6.6.8.1]
b. Jan 1935 d. Jan 1935
- 11 G. Stombaugh [1.1.1.1.1.4.2.6.6.8.2]
- 11 Lloyd Alvin Stoumbaugh [1.1.1.1.1.4.2.6.6.8.3]
b. 19 Aug 1940 d. 4 Jul 2018
Phyllis Wilma Archer b. 6 Oct 1941 d. 20 Nov 2006
- 12 W. Stoumbaugh [1.1.1.1.1.4.2.6.6.8.3.1]
- 12 Glenda Lynn Stoumbaugh [1.1.1.1.1.4.2.6.6.8.3.2]
b. 28 Feb 1960 d. 8 Jan 2020
- 12 Gailen Leroy Stoumbaugh [1.1.1.1.1.4.2.6.6.8.3.3]
b. 26 Mar 1961 d. 5 Aug 2015
- 12 W. Stoumbaugh [1.1.1.1.1.4.2.6.6.8.3.1]
- 11 Goldie Karean Stoumbaugh [1.1.1.1.1.4.2.6.6.8.4]
b. 18 Jan 1943 d. 27 Nov 2019
- + Daniel Edford Smith b. 3 Jun 1938 d. 10 Dec 2019
- + Daniel Edford Smith b. 3 Jun 1938 d. 10 Dec 2019
- 11 A. Stombaugh [1.1.1.1.1.4.2.6.6.8.5]
- 11 Cynthia Lee Stoumbaugh [1.1.1.1.1.4.2.6.6.8.6]
b. 7 Nov 1951 d. 5 Sep 2020
- + Rick Lee Hunt b. 1 Oct 1950 d. 16 Aug 2015
- + Rick Lee Hunt b. 1 Oct 1950 d. 16 Aug 2015
- 11 Richard Lee Stoumbaugh [1.1.1.1.1.4.2.6.6.8.1]
- 10 Muriel E Olmsted [1.1.1.1.1.4.2.6.6.9]
b. 1919 d. 11 Oct 1993
- 10 Deniece Delila Olmstead [1.1.1.1.1.4.2.6.6.1]
- 9 Delilia Jennetta McKee [1.1.1.1.1.4.2.6.7]
b. 2 Sep 1880 d. 20 Oct 1967
- 9 Rhoda Adeline McKee [1.1.1.1.1.4.2.6.8]
b. 23 Jan 1887 d. 20 Dec 1970
- 9 Myrtle Emily McKee [1.1.1.1.1.4.2.6.9]
b. 24 Jun 1891 d. 10 May 1983
Wallace Appleton Bent b. 16 Mar 1873 d. 9 Jul 1967
- 10 Robert Bruce Bent [1.1.1.1.1.4.2.6.9.1]
b. 30 Apr 1907 d. 16 Jan 1982
- 10 Emily Jean Bent [1.1.1.1.1.4.2.6.9.2]
b. 7 Nov 1920 d. 23 Sep 1996
Donald Wallace Buck b. 20 Sep 1919 d. 23 Nov 1995
- 11 Nola Joy Buck [1.1.1.1.1.4.2.6.9.2.1]
b. 27 Nov 1944 d. 27 Sep 2004
- 11 Nola Joy Buck [1.1.1.1.1.4.2.6.9.2.1]
- 10 Peggy Jean Bent [1.1.1.1.1.4.2.6.9.3]
b. 7 Nov 1920 d. 23 Sep 1996
- 10 Glenn Wilson Bent [1.1.1.1.1.4.2.6.9.4]
b. Abt 1924 d. 18 Mar 1955
- 10 Irvan Mckee Bent [1.1.1.1.1.4.2.6.9.5]
b. 10 Sep 1928 d. 2 Oct 1959
- 10 Robert Bruce Bent [1.1.1.1.1.4.2.6.9.1]
- 9 Artimas Samil (Artie) McKee [1.1.1.1.1.4.2.6.1]
- 8 Noah Milton Parson [1.1.1.1.1.4.2.7]
b. 12 Jan 1852 d. 12 Mar 1942
Emma Loretta Canfield b. 28 Feb 1861 d. 28 Feb 1919
- 9 Walter Timothy Parson [1.1.1.1.1.4.2.7.1]
b. 13 Aug 1880 d. 16 Feb 1926
Mary Elizabeth (Bessie) Akers b. 13 May 1884 d. 20 Jul 1954
- 10 Florence Lillian Parson [1.1.1.1.1.4.2.7.1.1]
b. 6 Jul 1902 d. 5 Oct 1993
William Roscoe Smart b. 16 Feb 1893 d. 26 Apr 1978
- 11 Lillian Mary Smart [1.1.1.1.1.4.2.7.1.1.1]
b. 20 Aug 1920 d. 31 Oct 1974
Louis Edgar Dickens b. 8 Mar 1912 d. 2009
- 12 E.E. Dickens [1.1.1.1.1.4.2.7.1.1.1.1]
[ =>]
- 12 L.K. Dickens [1.1.1.1.1.4.2.7.1.1.1.2]
[ =>]
- 12 S.L. Dickens [1.1.1.1.1.4.2.7.1.1.1.3]
- 12 C.G. Dickens [1.1.1.1.1.4.2.7.1.1.1.4]
[ =>]
- 12 G.L.A. Dickens [1.1.1.1.1.4.2.7.1.1.1.5]
[ =>]
- 12 R.M. Dickens [1.1.1.1.1.4.2.7.1.1.1.6]
[ =>]
- 12 R.D. Dickens [1.1.1.1.1.4.2.7.1.1.1.7]
[ =>]
- 12 E.E. Dickens [1.1.1.1.1.4.2.7.1.1.1.1]
- 11 Bonnie Lee Smart [1.1.1.1.1.4.2.7.1.1.2]
b. 5 Sep 1922 d. 23 Apr 2004
Wilson
- 12 E.L. Wilson [1.1.1.1.1.4.2.7.1.1.2.1]
[ =>]
- 12 E.L. Wilson [1.1.1.1.1.4.2.7.1.1.2.1]
- + Phillip Osborne Carlson b. 22 May 1922 d. 15 Feb 2016
Harlan Dale Evans b. 17 Oct 1921 d. 25 Feb 1978
- 12 S.S. Evans [1.1.1.1.1.4.2.7.1.1.2.2]
- 12 K.K. Evans [1.1.1.1.1.4.2.7.1.1.2.3]
[ =>]
- 12 T.L. Evans [1.1.1.1.1.4.2.7.1.1.2.4]
- 12 S.S. Evans [1.1.1.1.1.4.2.7.1.1.2.2]
- 11 R.L. Smart [1.1.1.1.1.4.2.7.1.1.3]
- 11 William Raymond Smart [1.1.1.1.1.4.2.7.1.1.4]
b. 16 Feb 1930 d. 2 Jun 2006
Wilma Jean Walters b. 20 Dec 1931 d. 14 Jul 2016
- 12 S.L. Smart [1.1.1.1.1.4.2.7.1.1.4.1]
- 12 S.L. Smart [1.1.1.1.1.4.2.7.1.1.4.1]
- 11 Lillian Mary Smart [1.1.1.1.1.4.2.7.1.1.1]
- 10 Emilee Bessie Parson [1.1.1.1.1.4.2.7.1.2]
b. 20 Feb 1904 d. 29 Jul 1977
Rolland Alfred Smart b. 16 Oct 1894 d. 30 Jun 1968
- 11 Alfred Walter Smart [1.1.1.1.1.4.2.7.1.2.1]
b. 4 Aug 1927 d. 20 Jun 2002
D.J. Johnson
- 12 P.J. Smart [1.1.1.1.1.4.2.7.1.2.1.1]
[ =>]
- 12 R.A. Smart [1.1.1.1.1.4.2.7.1.2.1.2]
[ =>]
- 12 J.K. Smart [1.1.1.1.1.4.2.7.1.2.1.3]
[ =>]
- 12 P.J. Smart [1.1.1.1.1.4.2.7.1.2.1.1]
- 11 Ronald Lee Smart [1.1.1.1.1.4.2.7.1.2.2]
b. 4 Jun 1945 d. 5 Jun 1945
- 11 Alfred Walter Smart [1.1.1.1.1.4.2.7.1.2.1]
- 10 Noah William Parson [1.1.1.1.1.4.2.7.1.3]
b. 24 Aug 1906 d. 8 Nov 1962
Frances Marie Bauman b. 7 Jul 1914 d. 9 Feb 2008
- 11 Mary Joan Parson [1.1.1.1.1.4.2.7.1.3.1]
b. 1 Nov 1933 d. 2 Jan 2020
Herbert Eugene Hammond b. 21 Jun 1931 d. 27 Nov 2014
- 12 T.S. Hammond [1.1.1.1.1.4.2.7.1.3.1.1]
- 12 Ronald Lee Hammond [1.1.1.1.1.4.2.7.1.3.1.2]
b. 11 Aug 1955 d. 27 Aug 2005 [ =>]
- 12 T.J. Hammond [1.1.1.1.1.4.2.7.1.3.1.3]
- 12 T.S. Hammond [1.1.1.1.1.4.2.7.1.3.1.1]
- 11 Mary Joan Parson [1.1.1.1.1.4.2.7.1.3.1]
- 10 Ernest Raymond Parson [1.1.1.1.1.4.2.7.1.4]
b. 25 Oct 1910 d. 5 Jan 1994
D. Carlson
- 11 C.B. Wyatt [1.1.1.1.1.4.2.7.1.4.1]
- 11 C.B. Wyatt [1.1.1.1.1.4.2.7.1.4.1]
- + Omega Dora Kunz b. 2 Sep 1919 d. Jun 1976
- + Isabel Spaeth b. Abt 1910 d. UNKNOWN
- 10 Florence Lillian Parson [1.1.1.1.1.4.2.7.1.1]
- 9 William Henry Parson [1.1.1.1.1.4.2.7.2]
b. 6 Oct 1881 d. 27 Mar 1940
Emma Leona Akers b. 2 Nov 1882 d. 10 May 1965
- 10 Henry Jacob Milton Parson [1.1.1.1.1.4.2.7.2.1]
b. 4 May 1907 d. 1 Mar 1966
Alberta Mae Greenwood b. 29 Jul 1906 d. 20 Jan 2000
- 11 L.J. Parson [1.1.1.1.1.4.2.7.2.1.1]
E.W. Allen
- 12 W.C. Allen [1.1.1.1.1.4.2.7.2.1.1.1]
- 12 R.E. Allen [1.1.1.1.1.4.2.7.2.1.1.2]
- 12 W.C. Allen [1.1.1.1.1.4.2.7.2.1.1.1]
- 11 L.J. Parson [1.1.1.1.1.4.2.7.2.1.1]
Helen Lattone Ivy b. 4 May 1914 d. 18 Jan 2002
- 11 J.D. Parson [1.1.1.1.1.4.2.7.2.1.2]
C. Petersen
- 12 T.P. Parson [1.1.1.1.1.4.2.7.2.1.2.1]
- 12 T.P. Parson [1.1.1.1.1.4.2.7.2.1.2.1]
- + M. Walsh
- 11 H.L. Parson [1.1.1.1.1.4.2.7.2.1.3]
- + W.L. Kirk
- + C.C. George
- + W.L. Kirk
- 11 J.D. Parson [1.1.1.1.1.4.2.7.2.1.2]
- 10 Sylvia Lenore Parson [1.1.1.1.1.4.2.7.2.2]
b. 18 Nov 1910 d. 29 Aug 1988
Marvin Rae Worman b. 11 Aug 1904 d. 16 Jul 1985
- 11 Norma Rae Worman [1.1.1.1.1.4.2.7.2.2.1]
b. 5 Dec 1930 d. 12 Feb 2023
D.C. Faelber
- 12 B.E. Faelber [1.1.1.1.1.4.2.7.2.2.1.1]
[ =>]
- 12 C.A. Faelber [1.1.1.1.1.4.2.7.2.2.1.2]
[ =>]
- 12 D.S. Faelber [1.1.1.1.1.4.2.7.2.2.1.3]
- 12 G.L. Faelber [1.1.1.1.1.4.2.7.2.2.1.4]
[ =>]
- 12 B.E. Faelber [1.1.1.1.1.4.2.7.2.2.1.1]
- 11 Marvin Eugene (Jack) Worman [1.1.1.1.1.4.2.7.2.2.2]
b. 29 Nov 1933 d. 20 Jul 2012
R. Shelley
- 12 Michael Shelly Worman [1.1.1.1.1.4.2.7.2.2.2.1]
b. 22 Dec 1954 d. Mar 1958
- 12 Michael Shelly Worman [1.1.1.1.1.4.2.7.2.2.2.1]
R.A. Schroeder
- 12 M.K. Worman [1.1.1.1.1.4.2.7.2.2.2.2]
[ =>]
- 12 M.K. Worman [1.1.1.1.1.4.2.7.2.2.2.2]
- 11 P.A. Worman [1.1.1.1.1.4.2.7.2.2.3]
D.C. Conley
- 12 Marvin Dale Conley [1.1.1.1.1.4.2.7.2.2.3.1]
b. 18 Aug 1954 d. 6 Mar 1981 [ =>]
- 12 C.M. Conley [1.1.1.1.1.4.2.7.2.2.3.2]
[ =>]
- 12 Marvin Dale Conley [1.1.1.1.1.4.2.7.2.2.3.1]
- 11 S.D. Worman [1.1.1.1.1.4.2.7.2.2.4]
James Lyle Hall b. 10 Mar 1933 d. 25 Aug 2017
- 11 F.L. Worman [1.1.1.1.1.4.2.7.2.2.5]
D.D. Lundquist
- 12 T.L. Worman [1.1.1.1.1.4.2.7.2.2.5.1]
- 12 Tonya Sue Worman [1.1.1.1.1.4.2.7.2.2.5.2]
b. 18 Jul 1966 d. 18 Jul 1966
- 12 J.P. Worman [1.1.1.1.1.4.2.7.2.2.5.3]
- 12 S.D. Worman [1.1.1.1.1.4.2.7.2.2.5.4]
- 12 T.L. Worman [1.1.1.1.1.4.2.7.2.2.5.1]
- 11 Norma Rae Worman [1.1.1.1.1.4.2.7.2.2.1]
- 10 Henry Jacob Milton Parson [1.1.1.1.1.4.2.7.2.1]
- 9 Nellie Maude Parson [1.1.1.1.1.4.2.7.3]
b. 12 Aug 1884 d. 26 Dec 1956
Lewis Mark Daniel Perdue b. 15 May 1884 d. 12 Sep 1967
- 10 Claude Milton Perdue [1.1.1.1.1.4.2.7.3.1]
b. 5 Oct 1908 d. 5 Dec 1991
- + Edythe Amber Rodgers b. 20 Feb 1906 d. 29 Jul 1995
- + Anne Elizabeth Brown b. 11 Mar 1904 d. 28 Jul 1975
- + Lillian Genive Herring b. 5 Nov 1917 d. 23 Sep 2003
- + Edythe Amber Rodgers b. 20 Feb 1906 d. 29 Jul 1995
- 10 Amanda Loretta Perdue [1.1.1.1.1.4.2.7.3.2]
b. 15 Nov 1910 d. 7 May 2002
Austin Anderson (Billy) Sims b. 25 Nov 1907 d. 14 Feb 1976
- 11 Billy Raymond Sims [1.1.1.1.1.4.2.7.3.2.1]
b. 28 Apr 1934 d. 9 Feb 2000
- 11 W.S. Sims [1.1.1.1.1.4.2.7.3.2.2]
- 11 Billy Raymond Sims [1.1.1.1.1.4.2.7.3.2.1]
- 10 Winifred Ethel (Shorty) Perdue [1.1.1.1.1.4.2.7.3.3]
b. 21 Mar 1912 d. 31 Aug 2013
- + Clyde Herman Strahan b. 25 Aug 1917 d. 14 Jul 1966
- + Clyde Herman Strahan b. 25 Aug 1917 d. 14 Jul 1966
- 10 Mildred Irene Perdue [1.1.1.1.1.4.2.7.3.4]
b. 6 Aug 1915 d. 4 Sep 1998
Harry Thomas David b. 23 Jul 1909 d. 21 Sep 1990
- 11 P.A. David [1.1.1.1.1.4.2.7.3.4.1]
S.C. Middleton
- 12 C.W. Middleton [1.1.1.1.1.4.2.7.3.4.1.1]
- 12 C.W. Middleton [1.1.1.1.1.4.2.7.3.4.1.1]
- 11 D.L. David [1.1.1.1.1.4.2.7.3.4.2]
- 11 P.A. David [1.1.1.1.1.4.2.7.3.4.1]
- 10 Geraldine Goldie Perdue [1.1.1.1.1.4.2.7.3.5]
b. 7 Mar 1919 d. 21 Oct 1993
John Warren Johnson, Jr b. 14 Jul 1915 d. 21 Oct 1993
- 11 S.K. Johnson [1.1.1.1.1.4.2.7.3.5.1]
James Ray Harmon b. 14 Jul 1938 d. 5 Jan 1983
- 12 L.K. Harmon [1.1.1.1.1.4.2.7.3.5.1.1]
- 12 L.K. Harmon [1.1.1.1.1.4.2.7.3.5.1.1]
- 11 S.K. Johnson [1.1.1.1.1.4.2.7.3.5.1]
- 10 Lewis Daniel (L D) Perdue [1.1.1.1.1.4.2.7.3.6]
b. 7 Mar 1919 d. 30 Jul 1942
- + Florine Nolia Glenn b. 7 Apr 1920 d. 24 Oct 2010
- + Florine Nolia Glenn b. 7 Apr 1920 d. 24 Oct 2010
- 10 Claude Milton Perdue [1.1.1.1.1.4.2.7.3.1]
- 9 John Daniel Parson [1.1.1.1.1.4.2.7.4]
b. 27 Dec 1886 d. 11 Jun 1978
Mabel Isola Stogsdill b. 19 May 1895 d. 20 Aug 1990
- 10 Hazel Evelyn Parson [1.1.1.1.1.4.2.7.4.1]
b. 25 Aug 1922 d. 17 May 2011
Arthur James White b. 3 Aug 1917 d. 8 May 1989
- 11 James Edward White [1.1.1.1.1.4.2.7.4.1.1]
b. 15 Jan 1953 d. 21 Apr 1999
- 11 D.M. White [1.1.1.1.1.4.2.7.4.1.2]
- 11 S.A. White [1.1.1.1.1.4.2.7.4.1.3]
V.J. Feurer
- 12 S.A. White, Jr [1.1.1.1.1.4.2.7.4.1.3.1]
- 12 L.E. White [1.1.1.1.1.4.2.7.4.1.3.2]
- 12 S.A. White, Jr [1.1.1.1.1.4.2.7.4.1.3.1]
- 11 D.G. White [1.1.1.1.1.4.2.7.4.1.4]
S.K. McSweeney
- 12 M.C. White [1.1.1.1.1.4.2.7.4.1.4.1]
- 12 E.F. White [1.1.1.1.1.4.2.7.4.1.4.2]
- 12 A.J. White, II [1.1.1.1.1.4.2.7.4.1.4.3]
- 12 M.C. White [1.1.1.1.1.4.2.7.4.1.4.1]
- 11 P.A. White [1.1.1.1.1.4.2.7.4.1.5]
R.L. Spiegel
- 12 S.R. Spiegel [1.1.1.1.1.4.2.7.4.1.5.1]
- 12 S.R. Spiegel [1.1.1.1.1.4.2.7.4.1.5.1]
C.A. Wobker
- 12 A.M. Wobker [1.1.1.1.1.4.2.7.4.1.5.2]
- 12 G.R. Wobker [1.1.1.1.1.4.2.7.4.1.5.3]
- 12 A.M. Wobker [1.1.1.1.1.4.2.7.4.1.5.2]
- 11 M.L. White [1.1.1.1.1.4.2.7.4.1.6]
D.D. Kahler
- 12 D.S. Kahler [1.1.1.1.1.4.2.7.4.1.6.1]
- 12 K.J. Kahler [1.1.1.1.1.4.2.7.4.1.6.2]
- 12 D.S. Kahler [1.1.1.1.1.4.2.7.4.1.6.1]
- 11 James Edward White [1.1.1.1.1.4.2.7.4.1.1]
- 10 Hazel Evelyn Parson [1.1.1.1.1.4.2.7.4.1]
- 9 Goldie Mae Parson [1.1.1.1.1.4.2.7.5]
b. 7 Jun 1894 d. 27 Jan 1961
Archie Lewis Shrout b. 6 Aug 1890 d. 3 May 1949
- 10 Archie Raoul Shrout [1.1.1.1.1.4.2.7.5.1]
b. 15 Nov 1919 d. 11 Jun 1969
Adele Josephine Pandiscio b. 31 Aug 1920 d. 24 Sep 2019
- 11 A.R. Shrout, Jr [1.1.1.1.1.4.2.7.5.1.1]
S.E. Strother
- 12 L.A. Shrout [1.1.1.1.1.4.2.7.5.1.1.1]
- 12 R.D. Shrout [1.1.1.1.1.4.2.7.5.1.1.2]
- 12 D.C. Shrout [1.1.1.1.1.4.2.7.5.1.1.3]
- 12 L.A. Shrout [1.1.1.1.1.4.2.7.5.1.1.1]
- 11 R.D. Shrout [1.1.1.1.1.4.2.7.5.1.2]
M. Graves
- 12 M.M. Shrout [1.1.1.1.1.4.2.7.5.1.2.1]
- 12 C.E. Shrout [1.1.1.1.1.4.2.7.5.1.2.2]
- 12 M.M. Shrout [1.1.1.1.1.4.2.7.5.1.2.1]
- 11 J.D. Shrout [1.1.1.1.1.4.2.7.5.1.3]
N.L. Oglesby
- 12 S.J. Shrout [1.1.1.1.1.4.2.7.5.1.3.1]
- 12 D.L. Shrout [1.1.1.1.1.4.2.7.5.1.3.2]
- 12 S.J. Shrout [1.1.1.1.1.4.2.7.5.1.3.1]
- 11 Candice Marie Shrout [1.1.1.1.1.4.2.7.5.1.4]
b. 14 Nov 1965 d. 25 Jun 2015
- 11 A.R. Shrout, Jr [1.1.1.1.1.4.2.7.5.1.1]
- 10 Kenneth Warren Shrout, Sr [1.1.1.1.1.4.2.7.5.2]
b. 7 May 1921 d. 2 Oct 1971
Juanita Marie Campbell b. 1 Feb 1919 d. 29 Apr 2009
- 11 B.M. Shrout [1.1.1.1.1.4.2.7.5.2.1]
- 11 K.W. Shrout, Jr [1.1.1.1.1.4.2.7.5.2.2]
M.A. Uthoff
- 12 K. Shrout [1.1.1.1.1.4.2.7.5.2.2.1]
- 12 K.H. Shrout [1.1.1.1.1.4.2.7.5.2.2.2]
- 12 K. Shrout [1.1.1.1.1.4.2.7.5.2.2.1]
- 11 H.L. Shrout [1.1.1.1.1.4.2.7.5.2.3]
D. Glover
- 12 J. Shrout [1.1.1.1.1.4.2.7.5.2.3.1]
- 12 J. Shrout [1.1.1.1.1.4.2.7.5.2.3.1]
P.A. Hendrickson
- 11 B.M. Shrout [1.1.1.1.1.4.2.7.5.2.1]
- 10 Francis Eugene Shrout, Sr [1.1.1.1.1.4.2.7.5.3]
b. 26 Aug 1925 d. 18 Oct 1991
Leona Evelyn Cunningham b. 20 Sep 1925 d. 14 Feb 2003
- 11 P.J. Shrout [1.1.1.1.1.4.2.7.5.3.1]
Claude Alvin Asbury b. 29 Apr 1938 d. 24 Nov 2017
- 12 Tammy Lynn Asbury [1.1.1.1.1.4.2.7.5.3.1.1]
b. 11 Feb 1971 d. 6 Feb 2002 [ =>]
- 12 Tammy Lynn Asbury [1.1.1.1.1.4.2.7.5.3.1.1]
- 11 F.E. Shrout, Jr [1.1.1.1.1.4.2.7.5.3.2]
P.S. Graven
- 12 K.L. Shrout [1.1.1.1.1.4.2.7.5.3.2.1]
- 12 K.L. Shrout [1.1.1.1.1.4.2.7.5.3.2.2]
- 12 K.L. Shrout [1.1.1.1.1.4.2.7.5.3.2.1]
D.S. Arnold
- 12 J.G. Shrout [1.1.1.1.1.4.2.7.5.3.2.3]
- 12 J.G. Shrout [1.1.1.1.1.4.2.7.5.3.2.3]
- 11 D.J. Shrout [1.1.1.1.1.4.2.7.5.3.3]
G.W. Battagler
- 12 Troy William Battagler [1.1.1.1.1.4.2.7.5.3.3.1]
b. 15 Jan 1974 d. 16 Jan 1974
- 12 G.S. Battagler [1.1.1.1.1.4.2.7.5.3.3.2]
- 12 T.W. Battagler [1.1.1.1.1.4.2.7.5.3.3.3]
- 12 A.C. Battagler [1.1.1.1.1.4.2.7.5.3.3.4]
- 12 Troy William Battagler [1.1.1.1.1.4.2.7.5.3.3.1]
- 11 P.J. Shrout [1.1.1.1.1.4.2.7.5.3.1]
- 10 L.B. Shrout [1.1.1.1.1.4.2.7.5.4]
William Andrew Kammerich b. 13 Jun 1925 d. 26 Oct 2018
- 11 L.J. Kammerich [1.1.1.1.1.4.2.7.5.4.1]
J.R. Michael
- 12 N.A. Michael [1.1.1.1.1.4.2.7.5.4.1.1]
[ =>]
- 12 J.R. Michael, Jr [1.1.1.1.1.4.2.7.5.4.1.2]
[ =>]
- 12 N.A. Michael [1.1.1.1.1.4.2.7.5.4.1.1]
- 11 Robert Wayne Kammerich [1.1.1.1.1.4.2.7.5.4.2]
b. 3 Nov 1951 d. 21 May 2014
- + D.F. Winslow
D.A.E. Little
- 12 M.W. Kammerich [1.1.1.1.1.4.2.7.5.4.2.1]
- 12 M.W. Kammerich [1.1.1.1.1.4.2.7.5.4.2.1]
- + N.L. Thrasher
- + D.F. Winslow
- 11 Cynthia Ann Kammerich [1.1.1.1.1.4.2.7.5.4.3]
b. 1 Jan 1957 d. 27 Jul 2019
J.E. Hankins
- 12 B.M. Hankins [1.1.1.1.1.4.2.7.5.4.3.1]
- 12 J.A. Hankins [1.1.1.1.1.4.2.7.5.4.3.2]
[ =>]
- 12 B.M. Hankins [1.1.1.1.1.4.2.7.5.4.3.1]
- 11 L.J. Kammerich [1.1.1.1.1.4.2.7.5.4.1]
- 10 Archie Raoul Shrout [1.1.1.1.1.4.2.7.5.1]
- 9 Fairy Marie Parson [1.1.1.1.1.4.2.7.6]
b. 15 Aug 1897 d. 1 May 1985
Earl Joseph Banks, Sr b. 10 Feb 1898 d. 13 Jun 1970
- 10 Earl Joseph (E J) Banks, Jr [1.1.1.1.1.4.2.7.6.1]
b. 9 Aug 1923 d. 26 Jun 2011
Mary Louise Kemple b. 29 Mar 1924 d. 2 Jan 2006
- 11 L.G. Banks [1.1.1.1.1.4.2.7.6.1.1]
D.I. Redden
- 12 C.G. Banks [1.1.1.1.1.4.2.7.6.1.1.1]
[ =>]
- 12 D.S. Banks [1.1.1.1.1.4.2.7.6.1.1.2]
[ =>]
- 12 C.G. Banks [1.1.1.1.1.4.2.7.6.1.1.1]
- 11 Kenneth Lavern Banks [1.1.1.1.1.4.2.7.6.1.2]
b. 5 Oct 1949 d. 7 Jun 2012
Gwendolyn Irene Janes b. 4 Sep 1948 d. 24 May 2018
- 12 William Joseph Banks [1.1.1.1.1.4.2.7.6.1.2.1]
b. 30 Jul 1971 d. 25 Nov 2017
- 12 C.A. Banks [1.1.1.1.1.4.2.7.6.1.2.2]
[ =>]
- 12 S.D. Banks [1.1.1.1.1.4.2.7.6.1.2.3]
[ =>]
- 12 William Joseph Banks [1.1.1.1.1.4.2.7.6.1.2.1]
- + M.L. McAlister
J.K. Jordan
- 12 Z.R. Banks [1.1.1.1.1.4.2.7.6.1.2.4]
- 12 Z.R. Banks [1.1.1.1.1.4.2.7.6.1.2.4]
- 11 Lynda Ruth Banks [1.1.1.1.1.4.2.7.6.1.3]
b. 17 Jul 1951 d. 1 Jan 2017
Lonnie James (Shadtree) Butler b. 24 Jun 1950 d. 28 Nov 2007
- 12 T.J. Butler [1.1.1.1.1.4.2.7.6.1.3.1]
[ =>]
- 12 Michelle Lynn Butler [1.1.1.1.1.4.2.7.6.1.3.2]
b. 24 Oct 1970 d. 3 Jun 2004 [ =>]
- 12 T.J. Butler [1.1.1.1.1.4.2.7.6.1.3.1]
- + T.W. Darling
Mark Edward Litton b. 14 Dec 1955 d. 2 Feb 2024
- 12 M.L. Litton [1.1.1.1.1.4.2.7.6.1.3.3]
[ =>]
- 12 M.L. Litton [1.1.1.1.1.4.2.7.6.1.3.3]
- + T.G. Jenkins
- 11 R.L. Banks [1.1.1.1.1.4.2.7.6.1.4]
K. Gentry
- 12 M.G. Spain [1.1.1.1.1.4.2.7.6.1.4.1]
- 12 S.R. Spain [1.1.1.1.1.4.2.7.6.1.4.2]
[ =>]
- 12 M.G. Spain [1.1.1.1.1.4.2.7.6.1.4.1]
F.A. Dautenhahn
- 12 J.J. Banks [1.1.1.1.1.4.2.7.6.1.4.3]
[ =>]
- 12 A.C. Banks [1.1.1.1.1.4.2.7.6.1.4.4]
[ =>]
- 12 C.C. Banks [1.1.1.1.1.4.2.7.6.1.4.5]
- 12 J.J. Banks [1.1.1.1.1.4.2.7.6.1.4.3]
- + Q.K. Wilkes
- + L.L. Buhler
- 11 L.G. Banks [1.1.1.1.1.4.2.7.6.1.1]
- 10 Alva Dean Banks [1.1.1.1.1.4.2.7.6.2]
b. 16 Jan 1929 d. 29 Apr 2023
Zella Lucile James b. 16 Jul 1930 d. 30 Aug 2015
- 11 J.R. Banks [1.1.1.1.1.4.2.7.6.2.1]
L.J. Lemmon
- 12 L.A. Banks [1.1.1.1.1.4.2.7.6.2.1.1]
[ =>]
- 12 L.A. Banks [1.1.1.1.1.4.2.7.6.2.1.1]
- 11 M.D. Banks [1.1.1.1.1.4.2.7.6.2.2]
D.E. Schultz
- 12 D.M. Banks [1.1.1.1.1.4.2.7.6.2.2.1]
[ =>]
- 12 D.M. Banks [1.1.1.1.1.4.2.7.6.2.2.1]
- + J.A. Ash
- 11 B.L. Banks [1.1.1.1.1.4.2.7.6.2.3]
J.R. Davis
- 12 J.L. Davis [1.1.1.1.1.4.2.7.6.2.3.1]
[ =>]
- 12 J.R. Davis [1.1.1.1.1.4.2.7.6.2.3.2]
[ =>]
- 12 J.N. Davis [1.1.1.1.1.4.2.7.6.2.3.3]
[ =>]
- 12 J.L. Davis [1.1.1.1.1.4.2.7.6.2.3.1]
- 11 J.R. Banks [1.1.1.1.1.4.2.7.6.2.1]
- 10 Mildred Maxine Banks [1.1.1.1.1.4.2.7.6.3]
b. 20 Aug 1932 d. 10 Aug 2023
John Wesley (Dub) Scott, Jr b. 30 Aug 1932 d. 22 Dec 1997
- 11 V.L. Scott [1.1.1.1.1.4.2.7.6.3.1]
- 11 D.W. Scott [1.1.1.1.1.4.2.7.6.3.2]
Judy Lynette Harrington b. 15 Feb 1966 d. 7 Jan 2022
- 12 M.J. Scott [1.1.1.1.1.4.2.7.6.3.2.1]
- 12 E.A. Scott [1.1.1.1.1.4.2.7.6.3.2.2]
- 12 A.C. Scott [1.1.1.1.1.4.2.7.6.3.2.3]
- 12 M.J. Scott [1.1.1.1.1.4.2.7.6.3.2.1]
- 11 L.M. Scott [1.1.1.1.1.4.2.7.6.3.3]
L.C. Kerksiek
- 12 J.B. Kerksiek [1.1.1.1.1.4.2.7.6.3.3.1]
- 12 A.S. Kerksiek [1.1.1.1.1.4.2.7.6.3.3.2]
- 12 J.B. Kerksiek [1.1.1.1.1.4.2.7.6.3.3.1]
- + B.W. Anderson
- 11 V.L. Scott [1.1.1.1.1.4.2.7.6.3.1]
- 10 Earl Joseph (E J) Banks, Jr [1.1.1.1.1.4.2.7.6.1]
- 9 Walter Timothy Parson [1.1.1.1.1.4.2.7.1]
- 8 Mary Jane Parson [1.1.1.1.1.4.2.8]
b. Abt 1855 d. Mar 1894
- 8 Rebecca Ann Parson [1.1.1.1.1.4.2.9]
b. 4 Jan 1857 d. 11 Oct 1891
- 8 Timothy Abner Parson [1.1.1.1.1.4.2.10]
b. Jan 1859 d. Yes, date unknown
Mary C Hogan b. Sep 1857
- 9 Bessie L V Parson [1.1.1.1.1.4.2.10.1]
b. Sep 1886 d. Yes, date unknown
- 9 Karl Addison Parson [1.1.1.1.1.4.2.10.2]
b. 31 Aug 1890 d. 4 Dec 1965
- + Anna E _____ b. 16 Aug 1887 d. 2 Dec 1972
- + Ruth Octave Ream b. 6 May 1896 d. 18 Jul 1954
- + Anna E _____ b. 16 Aug 1887 d. 2 Dec 1972
- 9 Bessie L V Parson [1.1.1.1.1.4.2.10.1]
- 8 John Perry Parson [1.1.1.1.1.4.2.2]
- 7 Timothy Parson [1.1.1.1.1.4.3]
b. 1813 d. 1 Nov 1900
- 7 Jane Parson [1.1.1.1.1.4.4]
b. 1814 d. 20 Dec 1881
- 7 Rhoda Parson [1.1.1.1.1.4.5]
b. 1817
- 7 Matthias Parson [1.1.1.1.1.4.6]
b. 1818 d. 31 Oct 1895
- 7 Isabella Parson [1.1.1.1.1.4.7]
b. 1822
- 7 George Parson [1.1.1.1.1.4.8]
b. 1824 d. 23 Apr 1876
- 7 Milton Parson [1.1.1.1.1.4.9]
b. 5 Apr 1828
- 7 Marietta Ann Parson [1.1.1.1.1.4.10]
b. 1832 d. 16 Mar 1917
- 7 Abigail Parson [1.1.1.1.1.4.11]
b. 9 Jan 1832 d. 8 May 1903
Philander Curry b. 1 Mar 1824 d. 24 Apr 1885
- 8 Artemezia Curry [1.1.1.1.1.4.11.1]
b. 29 Sep 1852 d. 26 Jan 1902
- 8 Artemis Curry [1.1.1.1.1.4.11.2]
b. Abt 1853
- 8 James Berl Curry [1.1.1.1.1.4.11.3]
b. 18 Apr 1858 d. 12 Apr 1929
- 8 Matilda F Curry [1.1.1.1.1.4.11.4]
b. 30 Oct 1860 d. 12 Apr 1927
- 8 John W Curry [1.1.1.1.1.4.11.5]
b. Feb 1867 d. 29 May 1908
- 8 Artemezia Curry [1.1.1.1.1.4.11.1]
- 7 Martha H Parson [1.1.1.1.1.4.12]
b. 1835
- 7 S. Parsons [1.1.1.1.1.4.1]
- 6 Elizabeth Covault [1.1.1.1.1.5]
b. 17 Mar 1795 d. 28 Jun 1865
- 6 Bowen Covault [1.1.1.1.1.1]
- 5 Timothy Isaac Covalt [1.1.1.1.1]
- 4 Lois Pendleton [1.1.1.1]
- 3 Bryant "Brian" Pendleton [1.1.1]
- 2 Caleb F Pendleton [1.1]